TAIGA INVERSIONES EOLICAS SCR SA

Extinta

CMNO DE LA ZARZUELA 15 - EDIFICIO B, 2º, ARAVACA (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 14/09/2021

BLAS BOVILLE JAIME

Consejero
Cese: 14/09/2021

BLAS BOVILLE JAIME

Secretario
Cese: 14/09/2021

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Consejero
Cese: 14/09/2021

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Presidente
Cese: 14/09/2021

BERGARECHE GANDARIAS RAMON

Consejero
Cese: 14/09/2021

TAIGA MISTRAL GESTION SGEIC SA

Entidad gestora
Cese: 14/09/2021

ESPINOS GOZALVEZ LUCIA

Vicesecretario no consejero
Cese: 14/09/2021

TUÑON MERINO MARIA CRISTINA

Apoderado
Cese: 14/09/2021

TAIGA MISTRAL GESTION SGEIC SA

Apoderado
Cese: 14/09/2021

TUÑON MERINO CRISTINA

Apoderado
Nombramiento: 14/09/2021

BLAS BOVILLE JAIME

Liquidador
Nombramiento: 12/08/2020

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 12/08/2020

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 12/08/2020

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Presidente
Nombramiento: 12/08/2020

BERGARECHE GANDARIAS RAMON

Consejero
Cese: 29/06/2018

TUÑON MERINO MARIA CRISTINA

Vicesecretario no consejero
Cese: 29/06/2018

BOADA SUAREZ ALVARO

Consejero
Cese: 29/06/2018

BOADA SUAREZ ALVARO

Secretario
Cese: 29/06/2018

BAIGORRI MORENO LUQUE ALEJANDRO

Consejero
Cese: 29/06/2018

LUCAYA FORCADA FRANCISCO JORGE

Consejero
Nombramiento: 29/06/2018

ESPINOS GOZALVEZ LUCIA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 29/06/2018

BLAS BOVILLE JAIME

Consejero
Nombramiento: 29/06/2018

BLAS BOVILLE JAIME

Secretario
Cese: 04/01/2018

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 04/01/2018

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 13/10/2016

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 22/09/2015

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 06/08/2014

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 06/08/2014

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Consejero delegado
Nombramiento: 06/08/2014

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 06/08/2014

TUÑON ALVAREZ ANTONIO

Presidente
Nombramiento: 06/08/2014

BOADA SUAREZ ALVARO

Consejero
Nombramiento: 06/08/2014

BOADA SUAREZ ALVARO

Secretario
Nombramiento: 06/08/2014

BERGARECHE GANDARIAS RAMON

Consejero
Nombramiento: 06/08/2014

BAIGORRI MORENO LUQUE ALEJANDRO

Consejero
Nombramiento: 06/08/2014

LUCAYA FORCADA FRANCISCO JORGE

Consejero
Nombramiento: 04/10/2013

TUÑON MERINO CRISTINA

Apoderado
Cese: 23/08/2013

CAIXA CAPITAL FONDOS SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE

Consejero
Cese: 23/08/2013

TRENCHS SAINZ DE LA MAZA CARLOS

Representante

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by TAIGA INVERSIONES EOLICAS SCR SA

14/09/2021 Details of the advert (417532) Registry data: T 37698 , F 215, S 8, H M 453998, I/A 25 ( 7.09.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BLAS BOVILLE JAIME. Secretario: BLAS BOVILLE JAIME. Consejero: TUÑON ALVAREZ ANTONIO. Presidente: TUÑON ALVAREZ ANTONIO. Consejero: BERGARECHE GANDARIAS RAMON. Ent. Gestora: TAIGA MISTRAL GESTION SGEIC SA. VsecrNoConsj: ESPINOS GOZALVEZ LUCIA.

  • Revocaciones

    Apoderado: TUÑON MERINO MARIA CRISTINA;TAIGA MISTRAL GESTION SGEIC SA;TUÑON MERINO CRISTINA

  • Nombramientos

    Liquidador: BLAS BOVILLE JAIME.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

14/08/2020 Details of the advert (269495) Registry data: T 25207 , F 216, S 8, H M 453998, I/A 24 ( 7.08.20).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 5.647.320,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.451.880,00 Euros.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 4.706.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.745.780,00 Euros.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 12.863.340,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.882.440,00 Euros.

12/08/2020 Details of the advert (266004) Registry data: T 25207 , F 216, S 8, H M 453998, I/A 23 ( 5.08.20).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL. Consejero: TUÑON ALVAREZ ANTONIO. Presidente: TUÑON ALVAREZ ANTONIO. Consejero: BERGARECHE GANDARIAS RAMON.

29/07/2019 Details of the advert (328975) Registry data: T 25207 , F 215, S 8, H M 453998, I/A 22 (22.07.19).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 6.274.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.099.200,00 Euros.

29/06/2018 Details of the advert (273574) Registry data: T 25207 , F 214, S 8, H M 453998, I/A 21 (20.06.18).

  • Ceses/Dimisiones

    VsecrNoConsj: TUÑON MERINO MARIA CRISTINA. Consejero: BOADA SUAREZ ALVARO. Secretario: BOADA SUAREZ ALVARO. Consejero: BAIGORRI MORENO LUQUE ALEJANDRO;LUCAYA FORCADA FRANCISCO JORGE.

  • Nombramientos

    VsecrNoConsj: ESPINOS GOZALVEZ LUCIA. Consejero: BLAS BOVILLE JAIME. Secretario: BLAS BOVILLE JAIME.

04/01/2018 Details of the advert (5928) Registry data: T 25207 , F 214, S 8, H M 453998, I/A 20 (27.12.17).

  • Revocaciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

  • Nombramientos

    Auditor: DELOITTE SL.

13/10/2016 Details of the advert (412766) Registry data: T 25207 , F 213, S 8, H M 453998, I/A 19 ( 5.10.16).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

22/09/2015 Details of the advert (383707) Registry data: T 25207 , F 213, S 8, H M 453998, I/A 18 (15.09.15).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

06/08/2014 Details of the advert (323899) Registry data: T 25207 , F 213, S 8, H M 453998, I/A 17 (29.07.14).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

06/08/2014 Details of the advert (323898) Registry data: T 25207 , F 212, S 8, H M 453998, I/A 16 (29.07.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: TUÑON ALVAREZ ANTONIO.

  • Reelecciones

    Consejero: TUÑON ALVAREZ ANTONIO. Presidente: TUÑON ALVAREZ ANTONIO. Consejero: BOADA SUAREZ ALVARO. Secretario: BOADA SUAREZ ALVARO. Consejero: BERGARECHE GANDARIAS RAMON;BAIGORRI MORENO LUQUE ALEJANDRO;LUCAYA FORCADA FRANCISCO JORGE.

Mercantile Registry documents related: 21

#CVE
Date
State
BORME-A-2021-177-28 14/09/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-157-28 14/08/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-155-28 12/08/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-143-28 29/07/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-124-28 29/06/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-3-28 04/01/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-196-28 13/10/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-181-28 22/09/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-148-28 06/08/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-148-28 06/08/2014 Madrid Descargar