SYSBA NK INTERNATIONAL SL

Cierre provisional

LUGAR EDIFICIO GALICIA, BLOQUE CIUDAD DE LUGO, AP. (POBRA DE TRIVES (A)).
 Pobra de Trives, A, Ourense
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 17/08/2010

PEREZ VAZQUEZ CLEMENTINA

Apoderado solidario
Nombramiento: 17/08/2010

GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER

Apoderado solidario
Nombramiento: 17/08/2010

GONZALEZ PEREZ JON FRANCISCO

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/03/2010

PEREZ VAZQUEZ CLEMENTINA

Consejero
Nombramiento: 04/03/2010

PEREZ VAZQUEZ CLEMENTINA

Presidente
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER

Consejero
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER

Vicepresidente
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ PEREZ JOSE GREGORIO

Consejero
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ PEREZ JOSE GREGORIO

Secretario
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ PEREZ JON FRANCISCO

Tesorero
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ PEREZ JON FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ PEREZ ANALEN- KATARINA

Consejero
Nombramiento: 04/03/2010

GONZALEZ PEREZ ANALEN-KATARINA

Consejero delegado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SYSBA NK INTERNATIONAL SL

23/10/2020 Details of the advert (361083) Registry data: T 801 , F 71, S 8, H OR 12494, I/A 4 N (13.10.20).

  • Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas

13/01/2020 Details of the advert (20)

    13/01/2020 Details of the advert (29)

      13/01/2020 Details of the advert (26)

        13/01/2020 Details of the advert (23)

          22/01/2015 Details of the advert (27816) Registry data: T 801 , F 70, S 8, H OR 12494, I/A 4 (12.01.15).

          • Cambio de domicilio social

            LUGAR EDIFICIO GALICIA, BLOQUE CIUDAD DE LUGO, AP. (POBRA DE TRIVES (A)).

          10/08/2011 Details of the advert (274942)

          • Depósitos de cuentas anuales

            (Junio de 2011) Año: 2010

          18/07/2011 Details of the advert (215515)

          • Depósitos de cuentas anuales

            (Junio de 2011) Año: 2009

          17/08/2010 Details of the advert (322762) Registry data: T 801 , F 70, S 8, H OR 12494, I/A 3 ( 3.08.10).

          • Nombramientos

            Apo.Sol.: PEREZ VAZQUEZ CLEMENTINA;GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ PEREZ JON FRANCISCO.

          03/08/2010 Details of the advert (305128) Registry data: T 801 , F 68, S 8, H OR 12494, I/A 2 (21.07.10).

          • Otros Conceptos

            Se modifica el art. siete de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de las participaciones y se añaden los artículos siete bis, sobre la adquisición derivativa de participaciones, siete ter, sobre los derechos reales de las mismas y nueve bis, sobre el derecho de separación de la sociedad.

          Mercantile Registry documents related: 11

          #CVE
          Date
          State
          BORME-A-2020-206-32 23/10/2020 Ourense Descargar
          BORME-B-2020-7-32 13/01/2020 Ourense Descargar
          BORME-B-2020-7-32 13/01/2020 Ourense Descargar
          BORME-B-2020-7-32 13/01/2020 Ourense Descargar
          BORME-B-2020-7-32 13/01/2020 Ourense Descargar
          BORME-A-2015-14-32 22/01/2015 Ourense Descargar
          BORME-B-2011-152-32 10/08/2011 Ourense Descargar
          BORME-B-2011-136-32 18/07/2011 Ourense Descargar
          BORME-A-2010-157-32 17/08/2010 Ourense Descargar
          BORME-A-2010-147-32 03/08/2010 Ourense Descargar