SOCIETAT CATALANA DINVERSIO EN COOPERATIVES SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA

Cambio de denominación social

CALLE GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 635 - PTA 3
Barcelona  (08010)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 02/06/2015

KPMG AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Cese: 23/10/2014

ROVIRA GARCIA JOAN CARLES

Consejero
Cese: 23/10/2014

GENERALITAT DE CATALUNYA

Consejero
Cese: 23/10/2014

CATALUNYACAIXA CAPITAL SA

Consejero
Cese: 23/10/2014

PIERRE VALENTIN

Consejero
Cese: 23/10/2014

BERTRAN AIXUT IRENE

Consejero
Cese: 23/10/2014

ESFIN SA

Consejero
Cese: 23/10/2014

INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S

Consejero
Cese: 23/10/2014

TORRELLAS JOVANI MATIAS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 23/10/2014

GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 23/10/2014

CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

ROVIRA GARCIA JOAN CARLES

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

GENERALITAT DE CATALUNYA

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

ESFIN SA

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

BERTRAN AIXUT IRENE

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

PIERRE VALENTIN

Consejero
Nombramiento: 23/10/2014

COS GARCIA DAVID

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 23/10/2014

HUGUES SIBILLE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 23/10/2014

LOPEZ GARCIA XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 23/10/2014

CAÑETE DE CARDENAS RUBIRA RAFAEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 23/10/2014

CAIXASABADELL TINELIA SL

Comisión del inv.
Cese: 23/10/2014

ROVIRA GARCIA JOAN CARLES

Presidente de la comisión de inv.
Cese: 23/10/2014

ZAYAS SANZA FRANCISCO JAVIER

Secretario no consejero de la comisión de inv.
Cese: 23/10/2014

AHICART GUILLEN LLUIS

Vicesecretario no consejero de la comisión de inv.
Cese: 23/10/2014

ROVIRA GARCIA JOAN CARLES

Comisión del inv.
Cese: 23/10/2014

INVERCARTERA SAU

Comisión del inv.
Cese: 23/10/2014

INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S

Comisión del inv.
Cese: 17/02/2014

BRULL ORTIZ EDUARD

Consejero
Cese: 17/02/2014

BRULL ORTIZ EDUARD

Presidente
Nombramiento: 17/02/2014

CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL

Consejero
Nombramiento: 17/02/2014

CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL

Presidente
Nombramiento: 17/02/2014

COS GARCIA DAVID

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 09/01/2014

KPMG AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Cese: 23/10/2013

BRUGUERA PAYET LLUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 23/10/2013

GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 06/03/2013

FABREGAT CLOTET JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 06/03/2013

BRUGUERA PAYET LLUIS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/10/2012

KPMG AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 16/05/2012

KPMG AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Cese: 13/01/2012

FRANCH GALLES MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 13/01/2012

LOPEZ GARCIA XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SOCIETAT CATALANA DINVERSIO EN COOPERATIVES SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA

14/12/2015 Details of the advert (503835) Registry data: T 42167 , F 7, S 8, H B 374580, I/A 25 (27.11.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA SU ADAPTACION A LA LEGISLACION DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO.

  • Cambio de denominación social

    SOCIETAT CATALANA DINVERSIO EN COOPERATIVES SCR SA.

25/08/2015 Details of the advert (349593) Registry data: T 42167 , F 7, S 8, H B 374580, I/A 24 (14.08.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 3.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.137.740,00 Euros.

02/06/2015 Details of the advert (222717) Registry data: T 42167 , F 6, S 8, H B 374580, I/A 23 (25.05.15).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL.

23/10/2014 Details of the advert (425029) Registry data: T 42151 , F 150, S 8, H B 374580, I/A 21 (16.10.14).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: ROVIRA GARCIA JOAN CARLES;GENERALITAT DE CATALUNYA;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA;PIERRE VALENTIN;BERTRAN AIXUT IRENE;ESFIN SA;INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S. REPR.143 RRM: TORRELLAS JOVANI MATIAS;GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE. CONSEJERO: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL;ROVIRA GARCIA JOAN CARLES;GENERALITAT DE CATALUNYA;ESFIN SA;BERTRAN AIXUT IRENE;PIERRE VALENTIN. REPR.143 RRM: COS GARCIA DAVID;HUGUES SIBILLE;LOPEZ GARCIA XAVIER.

23/10/2014 Details of the advert (425028) Registry data: T 42167 , F 6, S 8, H B 374580, I/A 22 (16.10.14).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: CAÑETE DE CARDENAS RUBIRA RAFAEL. COMS.DEL.INV: CAIXASABADELL TINELIA SL. PRE.COMS.D.I: ROVIRA GARCIA JOAN CARLES. S.N.C.C.D.I.: ZAYAS SANZA FRANCISCO JAVIER. VS.N.C.C.D.I: AHICART GUILLEN LLUIS. COMS.DEL.INV: ROVIRA GARCIA JOAN CARLES;INVERCARTERA SAU;INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.498.507,50 Euros. Resultante Suscrito: 5.137.740,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    ART. 13.- MODIFICACION APARTADOS 3 Y 4. ART.16.-SUPRESION APARTADO 7.

24/07/2014 Details of the advert (304719) Registry data: T 42151 , F 150, S 8, H B 374580, I/A 20 (17.07.14).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.113.752,50 Euros. Resultante Suscrito: 6.636.247,50 Euros.

17/02/2014 Details of the advert (72459) Registry data: T 42151 , F 149, S 8, H B 374580, I/A 19 ( 6.02.14).

  • Desembolso de divindendos pasivos

    Desembolsado: 700.000,00 Euros.

17/02/2014 Details of the advert (72462) Registry data: T 42151 , F 149, S 8, H B 374580, I/A 18 ( 6.02.14).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BRULL ORTIZ EDUARD. PRESIDENTE: BRULL ORTIZ EDUARD.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL. PRESIDENTE: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL. REPR.143 RRM: COS GARCIA DAVID.

09/01/2014 Details of the advert (6044) Registry data: T 42151 , F 148, S 8, H B 374580, I/A 17 (30.12.13).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL.

23/10/2013 Details of the advert (452449) Registry data: T 42151 , F 148, S 8, H B 374580, I/A 16 (15.10.13).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: BRUGUERA PAYET LLUIS.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE.

Mercantile Registry documents related: 31

#CVE
Date
State
BORME-A-2015-237-08 14/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-161-08 25/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-102-08 02/06/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-203-08 23/10/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-203-08 23/10/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-139-08 24/07/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-32-08 17/02/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-32-08 17/02/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-5-08 09/01/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-203-08 23/10/2013 Barcelona Descargar