SOCIETAT CATALANA DINVERSIO EN COOPERATIVES SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
Cambio de denominación social
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 02/06/2015 | KPMG AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
| Cese: 23/10/2014 | ROVIRA GARCIA JOAN CARLES |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | GENERALITAT DE CATALUNYA |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | CATALUNYACAIXA CAPITAL SA |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | PIERRE VALENTIN |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | BERTRAN AIXUT IRENE |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | ESFIN SA |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S |
Consejero |
| Cese: 23/10/2014 | TORRELLAS JOVANI MATIAS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 23/10/2014 | GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 23/10/2014 | CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | ROVIRA GARCIA JOAN CARLES |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | GENERALITAT DE CATALUNYA |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | ESFIN SA |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | BERTRAN AIXUT IRENE |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | PIERRE VALENTIN |
Consejero |
| Nombramiento: 23/10/2014 | COS GARCIA DAVID |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 23/10/2014 | HUGUES SIBILLE |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 23/10/2014 | LOPEZ GARCIA XAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 23/10/2014 | CAÑETE DE CARDENAS RUBIRA RAFAEL |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 23/10/2014 | CAIXASABADELL TINELIA SL |
Comisión del inv. |
| Cese: 23/10/2014 | ROVIRA GARCIA JOAN CARLES |
Presidente de la comisión de inv. |
| Cese: 23/10/2014 | ZAYAS SANZA FRANCISCO JAVIER |
Secretario no consejero de la comisión de inv. |
| Cese: 23/10/2014 | AHICART GUILLEN LLUIS |
Vicesecretario no consejero de la comisión de inv. |
| Cese: 23/10/2014 | ROVIRA GARCIA JOAN CARLES |
Comisión del inv. |
| Cese: 23/10/2014 | INVERCARTERA SAU |
Comisión del inv. |
| Cese: 23/10/2014 | INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S |
Comisión del inv. |
| Cese: 17/02/2014 | BRULL ORTIZ EDUARD |
Consejero |
| Cese: 17/02/2014 | BRULL ORTIZ EDUARD |
Presidente |
| Nombramiento: 17/02/2014 | CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL |
Consejero |
| Nombramiento: 17/02/2014 | CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL |
Presidente |
| Nombramiento: 17/02/2014 | COS GARCIA DAVID |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 09/01/2014 | KPMG AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
| Cese: 23/10/2013 | BRUGUERA PAYET LLUIS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 23/10/2013 | GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 06/03/2013 | FABREGAT CLOTET JOSEP |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 06/03/2013 | BRUGUERA PAYET LLUIS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 25/10/2012 | KPMG AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 16/05/2012 | KPMG AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
| Cese: 13/01/2012 | FRANCH GALLES MARIA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 13/01/2012 | LOPEZ GARCIA XAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SOCIETAT CATALANA DINVERSIO EN COOPERATIVES SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
14/12/2015 Details of the advert (503835) Registry data: T 42167 , F 7, S 8, H B 374580, I/A 25 (27.11.15).
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA SU ADAPTACION A LA LEGISLACION DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO.
- Cambio de denominación social
SOCIETAT CATALANA DINVERSIO EN COOPERATIVES SCR SA.
25/08/2015 Details of the advert (349593) Registry data: T 42167 , F 7, S 8, H B 374580, I/A 24 (14.08.15).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 3.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.137.740,00 Euros.
02/06/2015 Details of the advert (222717) Registry data: T 42167 , F 6, S 8, H B 374580, I/A 23 (25.05.15).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL.
23/10/2014 Details of the advert (425029) Registry data: T 42151 , F 150, S 8, H B 374580, I/A 21 (16.10.14).
- Revocaciones
CONSEJERO: ROVIRA GARCIA JOAN CARLES;GENERALITAT DE CATALUNYA;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA;PIERRE VALENTIN;BERTRAN AIXUT IRENE;ESFIN SA;INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S. REPR.143 RRM: TORRELLAS JOVANI MATIAS;GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE. CONSEJERO: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL.
- Nombramientos
CONSEJERO: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL;ROVIRA GARCIA JOAN CARLES;GENERALITAT DE CATALUNYA;ESFIN SA;BERTRAN AIXUT IRENE;PIERRE VALENTIN. REPR.143 RRM: COS GARCIA DAVID;HUGUES SIBILLE;LOPEZ GARCIA XAVIER.
23/10/2014 Details of the advert (425028) Registry data: T 42167 , F 6, S 8, H B 374580, I/A 22 (16.10.14).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: CAÑETE DE CARDENAS RUBIRA RAFAEL. COMS.DEL.INV: CAIXASABADELL TINELIA SL. PRE.COMS.D.I: ROVIRA GARCIA JOAN CARLES. S.N.C.C.D.I.: ZAYAS SANZA FRANCISCO JAVIER. VS.N.C.C.D.I: AHICART GUILLEN LLUIS. COMS.DEL.INV: ROVIRA GARCIA JOAN CARLES;INVERCARTERA SAU;INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S.
- Reducción de Capital
Importe reducción: 1.498.507,50 Euros. Resultante Suscrito: 5.137.740,00 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
ART. 13.- MODIFICACION APARTADOS 3 Y 4. ART.16.-SUPRESION APARTADO 7.
24/07/2014 Details of the advert (304719) Registry data: T 42151 , F 150, S 8, H B 374580, I/A 20 (17.07.14).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 1.113.752,50 Euros. Resultante Suscrito: 6.636.247,50 Euros.
17/02/2014 Details of the advert (72459) Registry data: T 42151 , F 149, S 8, H B 374580, I/A 19 ( 6.02.14).
- Desembolso de divindendos pasivos
Desembolsado: 700.000,00 Euros.
17/02/2014 Details of the advert (72462) Registry data: T 42151 , F 149, S 8, H B 374580, I/A 18 ( 6.02.14).
- Revocaciones
CONSEJERO: BRULL ORTIZ EDUARD. PRESIDENTE: BRULL ORTIZ EDUARD.
- Nombramientos
CONSEJERO: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL. PRESIDENTE: CLADE DESENVOLUPAMENT SCCL. REPR.143 RRM: COS GARCIA DAVID.
09/01/2014 Details of the advert (6044) Registry data: T 42151 , F 148, S 8, H B 374580, I/A 17 (30.12.13).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL.
23/10/2013 Details of the advert (452449) Registry data: T 42151 , F 148, S 8, H B 374580, I/A 16 (15.10.13).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: BRUGUERA PAYET LLUIS.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE.
Mercantile Registry documents related: 31
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2015-237-08 | 14/12/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-161-08 | 25/08/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-102-08 | 02/06/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-203-08 | 23/10/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-203-08 | 23/10/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-139-08 | 24/07/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-32-08 | 17/02/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-32-08 | 17/02/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-5-08 | 09/01/2014 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-203-08 | 23/10/2013 | Barcelona | Descargar |