SMITHKLINE BEECHAM SA

Cambio de denominación social

CARRETERA AJALVIR (- KM 2,500)
 Alcalá de Henares, Madrid  (28806)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 30/05/2023

CEJAS CORDON ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 02/02/2023

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 12/12/2022

GONZALEZ MARTIN ENRIC ALEJANDRO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 12/12/2022

GOLEN DAGMARA DANUTA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 12/12/2022

TOMALAC KATARZYNA MARIA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 23/08/2022

BITZER MARCUS

Consejero
Cese: 23/08/2022

FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA

Apoderado
Cese: 23/08/2022

DIAZ GOMEZ MARIA ELISA

Apoderado solidario
Cese: 23/08/2022

JIMENEZ COLETO JOSEFA

Apoderado solidario
Cese: 23/08/2022

REDONDO NIETO JULIAN

Apoderado solidario
Cese: 23/08/2022

GARCIA-SOTO RETUERTA ROBERTO

Apoderado
Cese: 23/08/2022

MARIN GALLARDO CONCEPCION JULIA

Apoderado
Cese: 23/08/2022

MUÑOZ DIAZ ALFONSO

Apoderado
Cese: 23/08/2022

MUÑOZ DIAZ ALFONSO

Apoderado
Cese: 23/08/2022

VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Cese: 23/08/2022

MUÑOZ DIAZ ALFONSO

Apoderado mancomunado
Cese: 23/08/2022

VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER

Apoderado mancomunado
Cese: 23/08/2022

VIERA GUTIERREZ FATIMA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 23/08/2022

GARCIA GAZO LUIS DAMIAN

Apoderado solidario
Cese: 23/08/2022

DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO

Apoderado
Cese: 23/08/2022

RAMIREZ JUSTO MOISES

Apoderado
Cese: 23/08/2022

MARIN GALLARDO CONCEPCION- JULIA

Apoderado
Cese: 23/08/2022

CASTRO RUIZ MARIA DEL CARMEN

Apoderado
Cese: 23/08/2022

RAMIREZ JUSTO MOISES

Apoderado solidario
Cese: 23/08/2022

DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO

Apoderado solidario
Cese: 23/08/2022

FAUS HINDERSIN RAMON NICOLAU

Apoderado
Nombramiento: 23/08/2022

HUERTA PIEDRA ROSA MARIA

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2022

BOZENA LUKOMSKA VICTORIA

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2022

PINKOWSKA MALGORZATA KATARZYNA

Apoderado
Nombramiento: 26/04/2022

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINANCE LIMITE

Apoderado solidario
Nombramiento: 27/10/2021

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 25/10/2021

LOPEZ GONZALEZ IÑIGO

Consejero
Cese: 25/10/2021

FERNANDEZ PEÑA GARCIA TERESA

Apoderado solidario
Nombramiento: 25/10/2021

BELLO CANEDO MARIA OLGA

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SMITHKLINE BEECHAM SA

14/02/2024 Details of the advert (77790) Registry data: T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 250 ( 7.02.24).

  • Cambio de denominación social

    HALEON ALCALA, S.A.

30/05/2023 Details of the advert (245414) Registry data: T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 249 (23.05.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: CEJAS CORDON ANTONIO.

17/02/2023 Details of the advert (86062) Registry data: T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 248 (10.02.23).

  • Otros Conceptos

    Cambio del domicilio del socio único y cambio de denominación del mismo pasando de GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE(OVERSEAS) LIMITED a denominarese HALEONUK SERVICESLIMITED en virtud de acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2022.

02/02/2023 Details of the advert (57971) Registry data: T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 247 (26.01.23).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

12/12/2022 Details of the advert (541267) Registry data: T 36320 , F 18, S 8, H M 120046, I/A 246 ( 1.12.22).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: GONZALEZ MARTIN ENRIC ALEJANDRO;GOLEN DAGMARA DANUTA;TOMALAC KATARZYNA MARIA.

23/08/2022 Details of the advert (388229) Registry data: T 36320 , F 16, S 8, H M 120046, I/A 244 (16.08.22).

  • Reelecciones

    Consejero: BITZER MARCUS.

23/08/2022 Details of the advert (388230) Registry data: T 36320 , F 16, S 8, H M 120046, I/A 245 (16.08.22).

  • Revocaciones

    Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA. Apo.Sol.: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;JIMENEZ COLETO JOSEFA;REDONDO NIETO JULIAN. Apoderado: GARCIA-SOTO RETUERTA ROBERTO;MARIN GALLARDO CONCEPCION JULIA;MUÑOZ DIAZ ALFONSO;MUÑOZ DIAZ ALFONSO;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: MUÑOZ DIAZ ALFONSO;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: VIERA GUTIERREZ FATIMA. Apo.Sol.: GARCIA GAZO LUIS DAMIAN. Apoderado: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO;RAMIREZ JUSTO MOISES;MARIN GALLARDO CONCEPCION- JULIA;CASTRO RUIZ MARIA DEL CARMEN. Apo.Sol.: RAMIREZ JUSTO MOISES;DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO. Apoderado: FAUS HINDERSIN RAMON NICOLAU.

  • Nombramientos

    Apoderado: HUERTA PIEDRA ROSA MARIA.

22/07/2022 Details of the advert (342378) Registry data: T 36320 , F 15, S 8, H M 120046, I/A 243 (15.07.22).

  • Nombramientos

    Apoderado: BOZENA LUKOMSKA VICTORIA;PINKOWSKA MALGORZATA KATARZYNA.

26/04/2022 Details of the advert (185846) Registry data: T 36320 , F 15, S 8, H M 120046, I/A 242 (19.04.22).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINANCE LIMITE.

27/10/2021 Details of the advert (471481) Registry data: T 36320 , F 15, S 8, H M 120046, I/A 241 (20.10.21).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

Mercantile Registry documents related: 69

#CVE
Date
State
BORME-A-2024-32-28 14/02/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2023-100-28 30/05/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-34-28 17/02/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-23-28 02/02/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-234-28 12/12/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-160-28 23/08/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-160-28 23/08/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-140-28 22/07/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-79-28 26/04/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-207-28 27/10/2021 Madrid Descargar