SMART BURGER SL

Extinta

AV DE LALCALDE BARNILS 64-68 EDIF.B PL.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 01/12/2015

GALVEZ GIMENEZ MANUEL

Consejero
Cese: 01/12/2015

GALVEZ GIMENEZ MANUEL

Secretario
Cese: 01/12/2015

CORNUDELLA MARQUES JOAN

Consejero
Cese: 01/12/2015

CORNUDELLA MARQUES JOAN

Presidente
Cese: 01/12/2015

MUNTADAS PRIM LAFITA LUIS

Consejero
Cese: 01/12/2015

DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO

Liquidador
Nombramiento: 01/12/2015

DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO

Liquidador
Cese: 04/05/2015

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado solidario mancomunado
Cese: 25/02/2015

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

MESTRE MARTIN FRANCISCO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

RUBIO RODRIGUEZ ADELA

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2014

ROLDAN SORIA NOELIA

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

VALLE ZAYAS OLGA

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2014

RENOM LLONCH ANNA

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/05/2014

ASENSIO FERRET JORDI

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 09/05/2014

BERMUDO ESCRIBANO JUAN

Apoderado solidario
Cese: 13/03/2013

CARULLA FONT ARTUR

Consejero
Cese: 13/03/2013

CARULLA FONT ARTUR

Presidente
Cese: 13/03/2013

GALVEZ GIMENEZ MANUEL

Consejero
Cese: 13/03/2013

GALVEZ GIMENEZ MANUEL

Secretario
Cese: 13/03/2013

CORNUDELLA MARQUES JOAN

Consejero
Nombramiento: 13/03/2013

GALVEZ GIMENEZ MANUEL

Consejero
Nombramiento: 13/03/2013

GALVEZ GIMENEZ MANUEL

Secretario
Nombramiento: 13/03/2013

CORNUDELLA MARQUES JOAN

Consejero
Nombramiento: 13/03/2013

CORNUDELLA MARQUES JOAN

Presidente
Nombramiento: 13/03/2013

MUNTADAS PRIM LAFITA LUIS

Consejero
Cese: 29/12/2011

PEREIRA DAVILA VICTOR

Apoderado
Cese: 21/12/2011

DEL RIO FERNANDEZ JOSE

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

ROLDAN SORIA NOELIA

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

BERMUDO ESCRIBANO JUAN

Apoderado
Cese: 11/05/2011

JEREZ BURDEUS SONIA

Apoderado
Cese: 11/05/2011

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 11/05/2011

DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 11/05/2011

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Cese: 03/05/2010

CHINCHILLA LOPEZ JORDI

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

JEREZ BURDEUS SONIA

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

JUANES RIPOLL CARMEN

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2010

MESTRE MARTIN FRANCISCO JOSE

Apoderado
Cese: 03/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado
Cese: 03/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado
Cese: 03/05/2010

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Cese: 03/05/2010

JEREZ BURDEUS SONIA

Apoderado
Cese: 03/05/2010

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Apoderado
Cese: 03/05/2010

MARTINEZ DE PABLO MARIA TERESA

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SMART BURGER SL

01/12/2015 Details of the advert (485554) Registry data: T 41393 , F 55, S 8, H B 378813, I/A 17 (24.11.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: GALVEZ GIMENEZ MANUEL. SECRETARIO: GALVEZ GIMENEZ MANUEL. CONSEJERO: CORNUDELLA MARQUES JOAN. PRESIDENTE: CORNUDELLA MARQUES JOAN. CONSEJERO: MUNTADAS PRIM LAFITA LUIS. LIQUIDADOR: DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO.

  • Nombramientos

    LIQUIDADOR: DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO.

  • Extinción

04/05/2015 Details of the advert (180177) Registry data: T 41393 , F 55, S 8, H B 378813, I/A 16 (23.04.15).

  • Revocaciones

    APOD.SOL/MAN: FERRER PELLICER IGNACIO.

25/02/2015 Details of the advert (81683) Registry data: T 41393 , F 55, S 8, H B 378813, I/A 15 (17.02.15).

  • Revocaciones

    APOD.SOL/MAN: IGLESIAS PUJOL IGNACIO.

09/05/2014 Details of the advert (194629) Registry data: T 41393 , F 50, S 8, H B 378813, I/A 14 (28.04.14).

  • Nombramientos

    APOD.SOL/MAN: FERRER PELLICER IGNACIO;XAMPENY TERRISSE VICTOR;DOMINGO GISPERT ANTONIO;DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO;IGLESIAS PUJOL IGNACIO;MESTRE MARTIN FRANCISCO. APODERAD.SOL: RUBIO RODRIGUEZ ADELA. APOD.SOL/MAN: ROLDAN SORIA NOELIA. APODERAD.SOL: VALLE ZAYAS OLGA;RENOM LLONCH ANNA. APOD.SOL/MAN: ASENSIO FERRET JORDI. APODERAD.SOL: BERMUDO ESCRIBANO JUAN.

11/03/2014 Details of the advert (109165) Registry data: T 41393 , F 50, S 8, H B 378813, I/A 13 ( 3.03.14).

  • Cambio de domicilio social

    AV DE LALCALDE BARNILS 64-68 EDIF.B PL.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).

13/03/2013 Details of the advert (123031) Registry data: T 41393 , F 50, S 8, H B 378813, I/A 12 ( 6.03.13).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: CARULLA FONT ARTUR. PRESIDENTE: CARULLA FONT ARTUR. CONSEJERO: GALVEZ GIMENEZ MANUEL. SECRETARIO: GALVEZ GIMENEZ MANUEL. CONSEJERO: CORNUDELLA MARQUES JOAN.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: GALVEZ GIMENEZ MANUEL. SECRETARIO: GALVEZ GIMENEZ MANUEL. CONSEJERO: CORNUDELLA MARQUES JOAN. PRESIDENTE: CORNUDELLA MARQUES JOAN. CONSEJERO: MUNTADAS PRIM LAFITA LUIS.

29/12/2011 Details of the advert (520778) Registry data: T 41393 , F 49, S 8, H B 378813, I/A 11 (21.12.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: PEREIRA DAVILA VICTOR.

21/12/2011 Details of the advert (506915) Registry data: T 41393 , F 48, S 8, H B 378813, I/A 10 ( 7.12.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: DEL RIO FERNANDEZ JOSE.

  • Nombramientos

    APODERADO: ROLDAN SORIA NOELIA;BERMUDO ESCRIBANO JUAN.

22/11/2011 Details of the advert (953501)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2011) Año: 2010

11/05/2011 Details of the advert (200719) Registry data: T 41393 , F 45, S 8, H B 378813, I/A 9 (29.04.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: JEREZ BURDEUS SONIA;IGLESIAS PUJOL IGNACIO.

  • Nombramientos

    APODERADO: DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO;IGLESIAS PUJOL IGNACIO.

Mercantile Registry documents related: 19

#CVE
Date
State
BORME-A-2015-229-08 01/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-82-08 04/05/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-38-08 25/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-87-08 09/05/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-48-08 11/03/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-50-08 13/03/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-246-08 29/12/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-240-08 21/12/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-221-08 22/11/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-89-08 11/05/2011 Barcelona Descargar