SITIO DE TORREKOLANDA SL

Activa

C/ PINAR 5 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 16/12/2016

PORTELA ALVAREZ MARCIAL

Apoderado
Nombramiento: 16/12/2016

GOMETZA ONAINDIA ISABEL

Apoderado
Cese: 20/01/2015

PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH

Consejero
Cese: 20/01/2015

PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH

Presidente
Nombramiento: 20/01/2015

PORTELA SCHNEIDER CAROLINA

Presidente
Cese: 16/10/2013

GOMEZA ASCONDO RICARDO

Consejero
Nombramiento: 26/12/2012

PORTELA SCHNEIDER CAROLINA

Consejero
Nombramiento: 14/10/2011

PORTELA SCHNEIDER NATHALIE

Consejero delegado
Cese: 14/10/2011

PORTELA ALVAREZ MARCIAL

Consejero
Cese: 14/10/2011

PORTELA ALVAREZ MARCIAL

Presidente
Nombramiento: 14/10/2011

PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH

Consejero
Nombramiento: 14/10/2011

PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH

Presidente

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SITIO DE TORREKOLANDA SL

16/12/2016 Details of the advert (509781) Registry data: T 33163 , F 27, S 8, H M 596747, I/A 3 ( 7.12.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: PORTELA ALVAREZ MARCIAL;GOMETZA ONAINDIA ISABEL.

20/02/2015 Details of the advert (76639) Registry data: T 33163 , F 27, S 8, H M 596747, I/A 2 (11.02.15).

  • Cambio de domicilio social

    C/ PINAR 5 (MADRID).

20/01/2015 Details of the advert (21197) Registry data: T 4751 , F 101, S 8, H BI 47431, I/A 11 (13.01.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH. Presidente: PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH.

  • Nombramientos

    Presidente: PORTELA SCHNEIDER CAROLINA.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.424.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.875,00 Euros.

16/10/2013 Details of the advert (442765) Registry data: T 4751 , F 101, S 8, H BI 47431, I/A 10 ( 9.10.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GOMEZA ASCONDO RICARDO.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ALAMEDA MAZARREDO 9 2& (BILBAO).

28/02/2013 Details of the advert (101080) Registry data: T 4751 , F 100, S 8, H BI 47431, I/A 9 (15.02.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 8.699.625,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.475.375,00 Euros.

26/12/2012 Details of the advert (536720) Registry data: T 4751 , F 100, S 8, H BI 47431, I/A 8 (12.12.12).

  • Nombramientos

    Consejero: PORTELA SCHNEIDER CAROLINA.

14/10/2011 Details of the advert (408365) Registry data: T 4751 , F 100, S 8, H BI 47431, I/A 7 ( 4.10.11).

  • Nombramientos

    Con.Delegado: PORTELA SCHNEIDER NATHALIE.

14/10/2011 Details of the advert (408364) Registry data: T 4751 , F 99, S 8, H BI 47431, I/A 6 (29.09.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: PORTELA ALVAREZ MARCIAL. Presidente: PORTELA ALVAREZ MARCIAL.

  • Nombramientos

    Consejero: PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH. Presidente: PORTELA ALVAREZ MARIA ELISABETH.

10/10/2011 Details of the advert (765591)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

10/10/2011 Details of the advert (765235)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2009

Mercantile Registry documents related: 12

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-238-28 16/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-35-28 20/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-12-48 20/01/2015 Bizkaia Descargar
BORME-A-2013-198-48 16/10/2013 Bizkaia Descargar
BORME-A-2013-41-48 28/02/2013 Bizkaia Descargar
BORME-A-2012-246-48 26/12/2012 Bizkaia Descargar
BORME-A-2011-196-48 14/10/2011 Bizkaia Descargar
BORME-A-2011-196-48 14/10/2011 Bizkaia Descargar
BORME-B-2011-193-48 10/10/2011 Bizkaia Descargar
BORME-B-2011-193-48 10/10/2011 Bizkaia Descargar