SHERLOCK FILMS SL

Extinta

CL VERDI Num.32 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 22/12/2015

MEJIAS RODRIGUEZ RAQUEL

Apoderado
Cese: 22/12/2015

ARGUELLES CARRERA ALEJANDRA

Apoderado
Cese: 22/12/2015

PEREZ MEJIAS ADRIAN

Apoderado
Nombramiento: 22/12/2015

RIERA FISCHER FERNANDO

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/12/2015

SERRATOSA FIGUEROLA FERRETTI RAFAEL CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/12/2015

GRANDES CARCI ALBERTO

Apoderado solidario
Nombramiento: 28/10/2015

ESCUDERO ZULOAGA EDUARDO

Administrador único
Cese: 27/08/2015

PEREZ FONT ENRIQUE

Administrador
Nombramiento: 11/05/2010

PEREZ MEJIAS ADRIAN

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SHERLOCK FILMS SL

18/04/2018 Details of the advert (169165) Registry data: T 34502 , F 127, S 8, H B 151859, I/A 19 ( 9.04.18).

  • Extinción

18/04/2018 Details of the advert (169160) Registry data: T 34502 , F 126, S 8, H B 151859, I/A 18 ( 9.04.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 107.679,00 Euros. Resultante Suscrito: 358.931,60 Euros.

  • Otros Conceptos

    PERDIDA DE UNIPERSONALIDAD.-

18/04/2018 Details of the advert (169157) Registry data: T 34502 , F 126, S 8, H B 151859, I/A 17 ( 9.04.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 251.252,60 Euros.

  • Cambio de domicilio social

    CL VERDI Num.32 (BARCELONA).

20/01/2017 Details of the advert (30739) Registry data: T 34502 , F 126, S 8, H B 151859, I/A 16 (12.01.17).

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: A CONTRACORRIENTE FILMS SL.

22/12/2015 Details of the advert (517015) Registry data: T 34502 , F 125, S 8, H B 151859, I/A 14 (11.12.15).

  • Revocaciones

    APODERADO: MEJIAS RODRIGUEZ RAQUEL;ARGUELLES CARRERA ALEJANDRA;PEREZ MEJIAS ADRIAN.

22/12/2015 Details of the advert (517016) Registry data: T 34502 , F 125, S 8, H B 151859, I/A 15 (11.12.15).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: RIERA FISCHER FERNANDO;SERRATOSA FIGUEROLA FERRETTI RAFAEL CARLOS;GRANDES CARCI ALBERTO.

28/10/2015 Details of the advert (433195) Registry data: T 34502 , F 125, S 8, H B 151859, I/A 13 (21.10.15).

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: ESCUDERO ZULOAGA EDUARDO.

27/08/2015 Details of the advert (353181) Registry data: T 34502 , F 125, S 8, H B 151859, I/A 12 (19.08.15).

  • Revocaciones

    ADMINISTR.: PEREZ FONT ENRIQUE.

26/09/2011 Details of the advert (619011)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

24/11/2010 Details of the advert (1087303)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

Mercantile Registry documents related: 12

#CVE
Date
State
BORME-A-2018-75-08 18/04/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-75-08 18/04/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-75-08 18/04/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-14-08 20/01/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-243-08 22/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-243-08 22/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-206-08 28/10/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-163-08 27/08/2015 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-183-08 26/09/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-225-08 24/11/2010 Barcelona Descargar