SG HOLDING DE VALORES Y PARTICIPACIONES SL

Activa

C/ SERRANO 41 4 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 28/01/2019

FRENEAU OLIVIER

Apoderado
Nombramiento: 28/01/2019

COMA BRUN JUAN PABLO

Apoderado
Nombramiento: 28/01/2019

ROZAS CANO IÑIGO

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

INTERTRUST (SPAIN) SL

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

FREIRE VILLANOVA ANA

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

DIEZ ARRANZ BEATRIZ

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

GONZALEZ YAÑEZ DANIEL

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

GIL MESINO MIGUEL

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

MORATO ESCRIVA DE BALAGUER MIGUEL MARIA

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

MARTINEZ- AVIAL BERGAMIN JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

LOPEZ-TEIJON LOPEZ JULIO

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

CASTAÑON MARTINEZ ESPERANZA

Apoderado
Nombramiento: 09/01/2019

UTRILLA FERNANDEZ- BERMEJO CRISTINA

Apoderado
Cese: 31/12/2018

GONZALEZ SANCHEZ DONATO

Administrador solidario
Cese: 31/12/2018

FRENEAU OLIVIER

Administrador solidario
Nombramiento: 31/12/2018

INTERTRUST (SPAIN) SL

Secretario no consejero
Nombramiento: 31/12/2018

FREIRE VILLANOVA ANA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 31/12/2018

DIEZ ARRANZ BEATRIZ

Representante
Nombramiento: 31/12/2018

FRENEAU OLIVIER

Consejero
Nombramiento: 31/12/2018

COMA BRUN JUAN PABLO

Consejero
Nombramiento: 31/12/2018

ROZAS CANO IÑIGO

Consejero
Nombramiento: 31/12/2018

COMA BRUN JUAN PABLO

Presidente
Cese: 04/12/2012

CALMAESTRA LEYVA JOSE

Apoderado
Nombramiento: 04/12/2012

SANJOSE MERINO MARIA DE LAS MERCEDES

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 10/10/2011

BUTTAY SERGE

Apoderado
Cese: 03/02/2010

PLA GILBERT

Administrador solidario
Cese: 03/02/2010

FRENEAU OLIVIER

Apoderado
Nombramiento: 03/02/2010

FRENEAU OLIVIER

Administrador solidario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SG HOLDING DE VALORES Y PARTICIPACIONES SL

28/01/2019 Details of the advert (36514) Registry data: T 18314 , F 191, S 8, H M 317565, I/A 13 (21.01.19).

  • Nombramientos

    Apoderado: FRENEAU OLIVIER;COMA BRUN JUAN PABLO;ROZAS CANO IÑIGO.

09/01/2019 Details of the advert (6965) Registry data: T 18314 , F 190, S 8, H M 317565, I/A 12 (31.12.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SL;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;FREIRE VILLANOVA ANA;DIEZ ARRANZ BEATRIZ;GONZALEZ YAÑEZ DANIEL;GIL MESINO MIGUEL;MORATO ESCRIVA DE BALAGUER MIGUEL MARIA;MARTINEZ- AVIAL BERGAMIN JAVIER;LOPEZ-TEIJON LOPEZ JULIO;CASTAÑON MARTINEZ ESPERANZA;UTRILLA FERNANDEZ- BERMEJO CRISTINA.

31/12/2018 Details of the advert (525219) Registry data: T 18314 , F 190, S 8, H M 317565, I/A 11 (21.12.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: GONZALEZ SANCHEZ DONATO;FRENEAU OLIVIER.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: INTERTRUST (SPAIN) SL. VsecrNoConsj: FREIRE VILLANOVA ANA. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Consejero: FRENEAU OLIVIER;COMA BRUN JUAN PABLO;ROZAS CANO IÑIGO. Presidente: COMA BRUN JUAN PABLO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración.

  • Cambio de domicilio social

    C/ SERRANO 41 4 (MADRID).

08/02/2017 Details of the advert (63423) Registry data: T 18314 , F 189, S 8, H M 317565, I/A 10 ( 1.02.17).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 2.997.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros.

04/12/2012 Details of the advert (500864) Registry data: T 18314 , F 188, S 8, H M 317565, I/A 9 (23.11.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: CALMAESTRA LEYVA JOSE.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: SANJOSE MERINO MARIA DE LAS MERCEDES.

10/10/2011 Details of the advert (401697) Registry data: T 18314 , F 188, S 8, H M 317565, I/A 8 (28.09.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: BUTTAY SERGE.

05/08/2010 Details of the advert (282346)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2009

03/02/2010 Details of the advert (45363) Registry data: T 18314 , F 188, S 8, H M 317565, I/A 7 (25.01.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: PLA GILBERT.

  • Revocaciones

    Apoderado: FRENEAU OLIVIER.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: FRENEAU OLIVIER.

23/07/2009 Details of the advert (172891)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 9

#CVE
Date
State
BORME-A-2019-18-28 28/01/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-5-28 09/01/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-249-28 31/12/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-27-28 08/02/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2012-232-28 04/12/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-193-28 10/10/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-149-28 05/08/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-22-28 03/02/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-138-28 23/07/2009 Madrid Descargar