SETA-PROYECTOS INTERNACIONALES SL

Extinta

PASEO CASTELLANA 91 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 30/12/2015

TOLEDANO MARQUES MOISES MAURICIO

Representante
Cese: 30/12/2015

EUROFINSA SA

Administrador único
Cese: 12/05/2015

ARIAS RAMIRO MARIA DOLORES

Apoderado solidario
Cese: 12/05/2015

ARIAS RAMIRO BARTOLOME

Apoderado solidario
Nombramiento: 10/02/2015

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Nombramiento: 07/11/2014

VEGA INTRIAGO MARIA JOSE

Apoderado
Nombramiento: 07/11/2014

ABAD HERNANDO FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Cese: 18/09/2014

QUEIPO DE LLANO COMYN JAIME

Secretario
Cese: 18/09/2014

GARCIA ARROYO JUAN ANTONIO

Consejero
Cese: 18/09/2014

GARCIA ARROYO JUAN ANTONIO

Presidente
Cese: 18/09/2014

TOLEDANO MARQUES MAURICIO

Consejero
Cese: 18/09/2014

GARCIA PANADERO MARIA DEL CARMEN

Consejero
Cese: 18/09/2014

TOLEDANO MARQUES MAURICIO

Consejero delegado
Cese: 18/09/2014

RUIZ RUBIO GERARDO

Consejero
Nombramiento: 18/09/2014

EUROFINSA SA

Administrador único
Nombramiento: 18/09/2014

TOLEDANO MARQUES MOISES MAURICIO

Representante
Nombramiento: 20/11/2012

GARCIA PANADERO MARIA DEL CARMEN

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 20/11/2012

GARCIA PANADERO JUAN ANTONIO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 20/11/2012

RUIZ RUBIO GERARDO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 20/11/2012

QUERUB CARO DAVID ALEXANDRE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 20/11/2012

ARIAS RAMIRO MARIA DOLORES

Apoderado solidario
Nombramiento: 20/11/2012

ARIAS RAMIRO BARTOLOME

Apoderado solidario
Nombramiento: 20/11/2012

TORRES MESAS RAFAEL

Apoderado solidario
Cese: 20/11/2012

PASCUAL OLMEDO JUAN JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/10/2012

RUIZ RUBIO GERARDO

Consejero
Nombramiento: 18/10/2012

QUEIPO DE LLANO COMYN JAIME

Secretario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SETA-PROYECTOS INTERNACIONALES SL

26/01/2016 Details of the advert (31803) Registry data: T 28316 , F 30, S 8, H M 353271, I/A 29 (21.12.15).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

    Fedeerratas:

  • Fe de erratas

    SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 29& LA PUBLICACION DEL ACTO DE DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD POR FUSION.

30/12/2015 Details of the advert (529677) Registry data: T 28316 , F 30, S 8, H M 353271, I/A 29 (21.12.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: TOLEDANO MARQUES MOISES MAURICIO. Adm. Unico: EUROFINSA SA.

25/06/2015 Details of the advert (261588) Registry data: T 28316 , F 30, S 8, H M 353271, I/A 28 (18.06.15).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    CEDDEX CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y PROYECTOS SA.

12/05/2015 Details of the advert (192966) Registry data: T 28316 , F 30, S 8, H M 353271, I/A 27 ( 4.05.15).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: ARIAS RAMIRO MARIA DOLORES;ARIAS RAMIRO BARTOLOME.

10/02/2015 Details of the advert (57756) Registry data: T 28316 , F 30, S 8, H M 353271, I/A 26 ( 2.02.15).

  • Nombramientos

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

07/11/2014 Details of the advert (453455) Registry data: T 28316 , F 29, S 8, H M 353271, I/A 25 (31.10.14).

  • Nombramientos

    Apoderado: VEGA INTRIAGO MARIA JOSE.

07/11/2014 Details of the advert (453454) Registry data: T 28316 , F 29, S 8, H M 353271, I/A 24 (31.10.14).

  • Nombramientos

    Apoderado: ABAD HERNANDO FRANCISCO JAVIER.

18/09/2014 Details of the advert (371818) Registry data: T 28316 , F 28, S 8, H M 353271, I/A 23 (11.09.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: QUEIPO DE LLANO COMYN JAIME. Consejero: GARCIA ARROYO JUAN ANTONIO. Presidente: GARCIA ARROYO JUAN ANTONIO. Consejero: TOLEDANO MARQUES MAURICIO;GARCIA PANADERO MARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: TOLEDANO MARQUES MAURICIO. Consejero: RUIZ RUBIO GERARDO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: EUROFINSA SA. Representan: TOLEDANO MARQUES MOISES MAURICIO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

11/03/2014 Details of the advert (110969) Registry data: T 28316 , F 28, S 8, H M 353271, I/A 22 ( 3.03.14).

  • Cambio de domicilio social

    PASEO CASTELLANA 91 (MADRID).

20/11/2012 Details of the advert (475093) Registry data: T 28316 , F 27, S 8, H M 353271, I/A 20 ( 7.11.12).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: GARCIA PANADERO MARIA DEL CARMEN;GARCIA PANADERO JUAN ANTONIO;RUIZ RUBIO GERARDO;QUERUB CARO DAVID ALEXANDRE.

Mercantile Registry documents related: 21

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-16-28 26/01/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-248-28 30/12/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-118-28 25/06/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-88-28 12/05/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-27-28 10/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-214-28 07/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-214-28 07/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-178-28 18/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-48-28 11/03/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2012-222-28 20/11/2012 Madrid Descargar