SECOMSA AIGUES SL

Cambio de denominación social

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 23/01/2014

CASTILLO VALERO JOSE ANTONIO

Consejero
Cese: 23/01/2014

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Consejero
Cese: 23/01/2014

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Vicesecretario
Cese: 23/01/2014

MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO

Consejero
Cese: 23/01/2014

MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO

Vicepresidente
Cese: 23/01/2014

IVORRA OSETE JUAN VICENTE

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 23/01/2014

GIRALT VIA EMILI

Gerente
Nombramiento: 23/01/2014

GIRALT VIA EMILI

Consejero
Nombramiento: 23/01/2014

GUILERA NAVARRO EDUARDO

Consejero
Nombramiento: 23/01/2014

MARTINEZ GUZMAN OSCAR

Consejero
Nombramiento: 23/01/2014

CRISTIA ROCA JOAN

Vicepresidente segundo
Nombramiento: 23/01/2014

GIRALT VIA EMILI

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 23/01/2014

MARTINEZ GUZMAN OSCAR

Vicesecretario
Nombramiento: 23/01/2014

AZORIN POVEDA JORDI

Gerente
Nombramiento: 01/10/2013

JEREZ GONZALEZ MERCE

Apoderado
Cese: 06/05/2013

COLET GONZALO MARTA

Consejero
Nombramiento: 06/05/2013

CRISTIA ROCA JOAN

Consejero
Cese: 18/02/2013

BARGAS MUSOY LIDIA

Consejero
Cese: 18/02/2013

BARGAS MUSOY LIDIA

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/02/2013

DALMAU MALLAFRE MERCE

Consejero
Nombramiento: 18/02/2013

DALMAU MALLAFRE MERCE

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 05/12/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Consejero
Cese: 05/12/2011

VALLS CAMPS FRANCESC

Gerente
Cese: 05/12/2011

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SOCIEDAD LIMITADA

Auditor
Cese: 05/12/2011

VALLS CAMPS FRANCESC

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 05/12/2011

OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS SA

Auditor
Nombramiento: 05/12/2011

MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO

Consejero
Nombramiento: 05/12/2011

LAGUNA MARTINEZ ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 05/12/2011

MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO

Vicepresidente
Nombramiento: 05/12/2011

GIRALT VIA EMILI

Gerente
Cese: 20/09/2011

MASDEU ISERN JOSEP

Consejero
Cese: 20/09/2011

CASTELLNOU BARCELO JOSEP

Consejero
Cese: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP Mº

Consejero
Cese: 20/09/2011

RECASENS BERTRAN JOAN

Consejero
Cese: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP Mº

Presidente
Cese: 20/09/2011

MASDEU ISERN JOSEP

Vicepresidente
Cese: 20/09/2011

MAS NOLLA JOAN

Consejero delegado
Cese: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP Mº

Consejero delegado
Cese: 20/09/2011

MANUEL ABELLO JOAN

Secretario
Cese: 20/09/2011

MAS NOLLA JOAN

Consejero
Cese: 20/09/2011

MORANCHO LOPEZ FRANCISCO ASIS

Consejero
Cese: 20/09/2011

CASTILLO VALERO JOSE ANTONIO

Consejero
Cese: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP MARIA

Consejero delegado
Cese: 20/09/2011

IVORRA OSETE JUAN VICENTE

Consejero
Cese: 20/09/2011

IVORRA OSETE JUAN VICENTE

Consejero delegado
Cese: 20/09/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Consejero
Cese: 20/09/2011

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Consejero
Cese: 20/09/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Vicepresidente
Cese: 20/09/2011

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Vicesecretario
Cese: 20/09/2011

COLET GONZALO MARTA

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

CALATAYUD CASALS JOAQUM

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

DOMINGO BASORA AGUSTI

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

BARGAS MUSOY LIDIA

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

SALVAT MIRO GERARD

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

PEREZ SANCHEZ ANGELS

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP Mº

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

IVORRA OSETE JUAN VICENTE

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

CASTILLO VALERO JOSE ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

COLET GONZALO MARTA

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Consejero
Nombramiento: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP Mº

Presidente
Nombramiento: 20/09/2011

CALATAYUD CASALS JOAQUM

Vicepresidente primero
Nombramiento: 20/09/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Vicepresidente segundo
Nombramiento: 20/09/2011

IVORRA OSETE JUAN VICENTE

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 20/09/2011

BARGAS MUSOY LIDIA

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 20/09/2011

VIDAL MAS JOSEP Mº

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 20/09/2011

MANUEL ABELLO JOAN

Secretario
Nombramiento: 20/09/2011

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Vicesecretario
Nombramiento: 20/09/2011

VALLS CAMPS FRANCESC

Gerente
Nombramiento: 20/09/2011

GONZALEZ GIRONES MARIA CRISTINA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 30/05/2011

AMOROS CORBELLA FRANCESC XAVIER

Consejero
Nombramiento: 30/05/2011

COLET GONZALO MARTA

Consejero
Cese: 04/02/2011

SORIANO RUIZ SERGI MIQUEL

Consejero
Cese: 04/02/2011

SORIANO RUIZ SERGI MIQUEL

Vicepresidente
Cese: 04/02/2011

PINYOL RIBAS JOAN

Consejero
Cese: 04/02/2011

MOTA TORRES ELENA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 04/02/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Consejero
Nombramiento: 04/02/2011

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Consejero
Nombramiento: 04/02/2011

DE MIGUEL GOMEZ JONAS

Vicepresidente
Nombramiento: 04/02/2011

JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO

Vicesecretario
Nombramiento: 17/08/2009

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SOCIEDAD LIMITADA

Auditor
Cese: 11/08/2009

TOMAS BATLLE ANTONIO

Consejero
Cese: 11/08/2009

SALA PADROS PERE

Apoderado mancomunado
Cese: 11/08/2009

SALA PADROS PERE

Apoderado solidario
Cese: 11/08/2009

SALA PADROS PERE

Apoderado
Nombramiento: 11/08/2009

VALLS CAMPS FRANCESC

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 11/08/2009

AMOROS CORBELLA FRANCESC XAVIER

Consejero

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SECOMSA AIGUES SL

20/05/2014 Details of the advert (210097) Registry data: T 2500 , F 225, S 8, H T 32697, I/A 22 ( 9.05.14).

  • Otros Conceptos

    REFUNDIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

  • Cambio de denominación social

    COMAIGUA SOCIEDAD LIMITADA.

  • Cambio de objeto social

    El ambito territorial de actuación de la sociedad COMAIGUA SL comprende toda la comarca del Baix Camp, y su area de influencia que podra comprender todo el territorio de Catalunya.

23/01/2014 Details of the advert (31787) Registry data: T 2500 , F 221, S 8, H T 32697, I/A 21 (16.01.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CASTILLO VALERO JOSE ANTONIO;JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Vicesecret.: JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Consejero: MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO. Vicepresid.: MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO. Co.De.Ma.So: IVORRA OSETE JUAN VICENTE. Gerente: GIRALT VIA EMILI.

  • Nombramientos

    Consejero: GIRALT VIA EMILI;GUILERA NAVARRO EDUARDO;MARTINEZ GUZMAN OSCAR. Vicepr.2: CRISTIA ROCA JOAN. Co.De.Ma.So: GIRALT VIA EMILI. Vicesecret.: MARTINEZ GUZMAN OSCAR. Gerente: AZORIN POVEDA JORDI.

01/10/2013 Details of the advert (420769) Registry data: T 2500 , F 220, S 8, H T 32697, I/A 20 (19.09.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: JEREZ GONZALEZ MERCE.

06/05/2013 Details of the advert (206230) Registry data: T 2500 , F 220, S 8, H T 32697, I/A 19 (25.04.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: COLET GONZALO MARTA.

  • Nombramientos

    Consejero: CRISTIA ROCA JOAN.

18/02/2013 Details of the advert (80264) Registry data: T 2500 , F 219, S 8, H T 32697, I/A 18 ( 6.02.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BARGAS MUSOY LIDIA. Co.De.Ma.So: BARGAS MUSOY LIDIA.

  • Nombramientos

    Consejero: DALMAU MALLAFRE MERCE. Co.De.Ma.So: DALMAU MALLAFRE MERCE.

05/12/2011 Details of the advert (485746) Registry data: T 2500 , F 217, S 8, H T 32697, I/A 17 (21.11.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DE MIGUEL GOMEZ JONAS. Gerente: VALLS CAMPS FRANCESC.

  • Cancelaciones de oficio de nombramientos

    Auditor: FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SOCIEDAD LIMITADA.

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: VALLS CAMPS FRANCESC.

  • Nombramientos

    Auditor: OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS SA. Consejero: MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO;LAGUNA MARTINEZ ANTONIO. Vicepresid.: MARTINEZ LACAMBRA ALBERTO. Gerente: GIRALT VIA EMILI.

20/09/2011 Details of the advert (378352) Registry data: T 2500 , F 66, S 8, H T 32697, I/A 16 ( 8.09.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MASDEU ISERN JOSEP;CASTELLNOU BARCELO JOSEP;VIDAL MAS JOSEP Mº;RECASENS BERTRAN JOAN. Presidente: VIDAL MAS JOSEP Mº. Vicepresid.: MASDEU ISERN JOSEP. Con.Delegado: MAS NOLLA JOAN;VIDAL MAS JOSEP Mº. Secretario: MANUEL ABELLO JOAN. Consejero: MAS NOLLA JOAN;MORANCHO LOPEZ FRANCISCO ASIS;CASTILLO VALERO JOSE ANTONIO. Con.Delegado: VIDAL MAS JOSEP MARIA. Consejero: IVORRA OSETE JUAN VICENTE. Con.Delegado: IVORRA OSETE JUAN VICENTE. Consejero: DE MIGUEL GOMEZ JONAS;JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Vicepresid.: DE MIGUEL GOMEZ JONAS. Vicesecret.: JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Consejero: COLET GONZALO MARTA.

  • Nombramientos

    Consejero: CALATAYUD CASALS JOAQUM;DOMINGO BASORA AGUSTI;BARGAS MUSOY LIDIA;SALVAT MIRO GERARD;PEREZ SANCHEZ ANGELS;VIDAL MAS JOSEP Mº;DE MIGUEL GOMEZ JONAS;IVORRA OSETE JUAN VICENTE;CASTILLO VALERO JOSE ANTONIO;COLET GONZALO MARTA;JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Presidente: VIDAL MAS JOSEP Mº. Vicepr.1: CALATAYUD CASALS JOAQUM. Vicepr.2: DE MIGUEL GOMEZ JONAS. Co.De.Ma.So: IVORRA OSETE JUAN VICENTE;BARGAS MUSOY LIDIA;VIDAL MAS JOSEP Mº. Secretario: MANUEL ABELLO JOAN. Vicesecret.: JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Gerente: VALLS CAMPS FRANCESC. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GIRONES MARIA CRISTINA.

28/06/2011 Details of the advert (186891)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2011) Año: 2010

30/05/2011 Details of the advert (230680) Registry data: T 2500 , F 66, S 8, H T 32697, I/A 15 (18.05.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: AMOROS CORBELLA FRANCESC XAVIER.

  • Nombramientos

    Consejero: COLET GONZALO MARTA.

04/02/2011 Details of the advert (50026) Registry data: T 2500 , F 65, S 8, H T 32697, I/A 14 (24.01.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: SORIANO RUIZ SERGI MIQUEL. Vicepresid.: SORIANO RUIZ SERGI MIQUEL. Consejero: PINYOL RIBAS JOAN. VsecrNoConsj: MOTA TORRES ELENA.

  • Nombramientos

    Consejero: DE MIGUEL GOMEZ JONAS;JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO. Vicepresid.: DE MIGUEL GOMEZ JONAS. Vicesecret.: JIMENEZ MARCONI ALEJANDRO.

Mercantile Registry documents related: 16

#CVE
Date
State
BORME-A-2014-93-43 20/05/2014 Tarragona Descargar
BORME-A-2014-15-43 23/01/2014 Tarragona Descargar
BORME-A-2013-187-43 01/10/2013 Tarragona Descargar
BORME-A-2013-83-43 06/05/2013 Tarragona Descargar
BORME-A-2013-33-43 18/02/2013 Tarragona Descargar
BORME-A-2011-230-43 05/12/2011 Tarragona Descargar
BORME-A-2011-179-43 20/09/2011 Tarragona Descargar
BORME-B-2011-122-43 28/06/2011 Tarragona Descargar
BORME-A-2011-102-43 30/05/2011 Tarragona Descargar
BORME-A-2011-24-43 04/02/2011 Tarragona Descargar