SANTANDER CONSUMER MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SL

Extinta

AVDA DE CANTABRIA S/N - CIUDAD GRUPO SANTANDER (BOADILLA DEL MONTE).
 Boadilla del Monte, Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 24/12/2020

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 23/12/2020

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 10/07/2018

LOPEZ DE LA FUENTE RICARDO

Consejero
Nombramiento: 06/03/2018

JORGE JAVIER FRANCES ARMIÑANA

Apoderado
Nombramiento: 18/12/2017

RODRIGUEZ HJELM DEBORAH

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/12/2017

AGRAFOJO VAZQUEZ IRIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/12/2017

CARPENA NIÑO JOSE MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2017

SANCHEZ REPISO ROSA MARIA

Apoderado
Nombramiento: 02/11/2017

ROMERA SANCHEZ FULGENCIO

Apoderado
Cese: 03/11/2016

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 03/11/2016

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 16/09/2016

FRANCES ARMIÑANA JORGE JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 16/09/2016

VILLAREJO BLANCO RAFAEL

Apoderado
Nombramiento: 16/09/2016

NIETO DE LA CIERVA PEDRO

Apoderado
Nombramiento: 25/01/2016

DELOITTE SL

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by SANTANDER CONSUMER MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SL

06/08/2021 Details of the advert (373649) Registry data: T 35158 , F 69, S 8, H M 604404, I/A 16 (30.07.21).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

24/12/2020 Details of the advert (459747) Registry data: T 35158 , F 69, S 8, H M 604404, I/A 15 (17.12.20).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

23/12/2020 Details of the advert (456769) Registry data: T 35158 , F 68, S 8, H M 604404, I/A 14 (16.12.20).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

10/07/2018 Details of the advert (286709) Registry data: T 35158 , F 68, S 8, H M 604404, I/A 13 ( 3.07.18).

  • Nombramientos

    Consejero: LOPEZ DE LA FUENTE RICARDO.

06/03/2018 Details of the advert (105772) Registry data: T 35158 , F 68, S 8, H M 604404, I/A 12 (23.02.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: JORGE JAVIER FRANCES ARMIÑANA.

18/12/2017 Details of the advert (492403) Registry data: T 35158 , F 67, S 8, H M 604404, I/A 11 ( 5.12.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: RODRIGUEZ HJELM DEBORAH;AGRAFOJO VAZQUEZ IRIA;CARPENA NIÑO JOSE MARIA.

02/11/2017 Details of the advert (431466) Registry data: T 35158 , F 66, S 8, H M 604404, I/A 10 (24.10.17).

  • Nombramientos

    Apoderado: SANCHEZ REPISO ROSA MARIA;ROMERA SANCHEZ FULGENCIO.

03/11/2016 Details of the advert (443203) Registry data: T 33580 , F 150, S 8, H M 604404, I/A 9 (25.10.16).

  • Revocaciones

    Auditor: DELOITTE SL.

  • Nombramientos

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

16/09/2016 Details of the advert (378858) Registry data: T 33580 , F 149, S 8, H M 604404, I/A 8 ( 9.09.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: FRANCES ARMIÑANA JORGE JAVIER;VILLAREJO BLANCO RAFAEL.

16/09/2016 Details of the advert (378857) Registry data: T 33580 , F 148, S 8, H M 604404, I/A 7 ( 9.09.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: NIETO DE LA CIERVA PEDRO.

Mercantile Registry documents related: 16

#CVE
Date
State
BORME-A-2021-150-28 06/08/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-246-28 24/12/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-245-28 23/12/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2018-131-28 10/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-46-28 06/03/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-238-28 18/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-209-28 02/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-210-28 03/11/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-178-28 16/09/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-178-28 16/09/2016 Madrid Descargar