PROYECTO R5 SL
Extinta
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 31/10/2013 | ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | OZAMIZ ESTRADE JAVIER |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | VIZCAYA RETANA MARCOS |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | BAON MARTINEZ LUIS |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | CARDENAS HURTADO DE SARACHO IÑIGO |
Consejero |
| Cese: 31/10/2013 | ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO |
Presidente |
| Cese: 31/10/2013 | ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO |
Consejero delegado |
| Cese: 31/10/2013 | HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI MANUEL |
Vicesecretario |
| Cese: 31/10/2013 | PASTOR PINEDO IÑIGO |
Secretario |
| Nombramiento: 31/10/2013 | ISUSI GARTEIZ-GOGEASCOA ALBERTO |
Liquidador |
| Cese: 31/05/2011 | SANCHEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO |
Consejero |
| Nombramiento: 12/05/2010 | ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SLP |
Auditor |
| Nombramiento: 05/01/2010 | CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER |
Apoderado |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by PROYECTO R5 SL
31/10/2013 Details of the advert (466317) Registry data: T 27131 , F 82, S 8, H M 420181, I/A 10 (24.10.13).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO;CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER;ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE;OZAMIZ ESTRADE JAVIER;VIZCAYA RETANA MARCOS;BAON MARTINEZ LUIS;CARDENAS HURTADO DE SARACHO IÑIGO. Presidente: ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO. Con.Delegado: ISUSI GARTEIZ GOGEASCOA ALBERTO. Vicesecret.: HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI MANUEL. Secretario: PASTOR PINEDO IÑIGO.
- Nombramientos
Liquidador: ISUSI GARTEIZ-GOGEASCOA ALBERTO.
- Disolución
Voluntaria.
31/05/2011 Details of the advert (231682) Registry data: T 27131 , F 81, S 8, H M 420181, I/A 9 (19.05.11).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: SANCHEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO.
12/05/2011 Details of the advert (149888)
- Depósitos de cuentas anuales
(Abril de 2011) Año: 2010
04/04/2011 Details of the advert (149903) Registry data: T 27131 , F 80, S 8, H M 420181, I/A 8 (24.03.11).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 849.996,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.675.756,00 Euros.
15/06/2010 Details of the advert (205843)
- Depósitos de cuentas anuales
(Mayo de 2010) Año: 2009
12/05/2010 Details of the advert (190573) Registry data: T 27131 , F 80, S 8, H M 420181, I/A 7 (29.04.10).
- Nombramientos
Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SLP.
25/01/2010 Details of the advert (28606) Registry data: T 27131 , F 80, S 8, H M 420181, I/A 6 (14.01.10).
- Cambio de domicilio social
C/ PADILLA, 42, 1 (MADRID).
05/01/2010 Details of the advert (3695) Registry data: T 23427 , F 169, S 8, H M 420181, I/A 5 (23.12.09).
- Nombramientos
Apoderado: CARDENAL HURTADO DE SARACHO JAVIER.
22/06/2009 Details of the advert (148894)
- Depósitos de cuentas anuales
(Junio de 2009) Año: 2008
Mercantile Registry documents related: 9
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2013-209-28 | 31/10/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-103-28 | 31/05/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2011-90-28 | 12/05/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-65-28 | 04/04/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-112-28 | 15/06/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-89-28 | 12/05/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-15-28 | 25/01/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-2-28 | 05/01/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2009-115-28 | 22/06/2009 | Madrid | Descargar |