POWER SUPPORT SL

Cambio de denominación social

C/ VELAZQUEZ 150 3 - LOCAL 2 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 04/04/2016

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 29/07/2015

ROULAND XAVIER PASCAL

Representante
Nombramiento: 29/07/2015

GIL NUÑO ANA

Representante
Cese: 16/02/2015

BROUCHON JEAN JOLYOT

Consejero
Cese: 16/02/2015

BERTRAND RUIZ DE VELASCO IÑIGO

Consejero
Cese: 16/02/2015

CABRERA MENDEZ GERMAN FERNANDO

Consejero
Cese: 16/02/2015

KATCHAROV NICOLAS ANTONY

Consejero
Cese: 16/02/2015

ROULAND XAVIER PASCAL

Consejero
Cese: 16/02/2015

MARITANO MIRCO

Consejero
Cese: 16/02/2015

BILBAO GARAY ANE

Secretario no consejero
Cese: 16/02/2015

KATCHAROV NICOLAS ANTONY

Presidente
Cese: 16/02/2015

ROULAND XAVIER PASCAL

Vicepresidente
Cese: 16/02/2015

ROULAND XAVIER PASCAL

Consejero delegado
Nombramiento: 16/02/2015

FENICE INSTALACIONES IBERICA SL

Administrador único
Nombramiento: 16/02/2015

ROULAND XAVIER PASCAL

Representante
Nombramiento: 06/11/2014

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 03/10/2014

MARTINEZ DIAZ SUSANA

Apoderado
Cese: 30/09/2014

GAY PASCAL MAURICE RENE

Consejero
Nombramiento: 30/09/2014

MARITANO MIRCO

Consejero
Nombramiento: 30/09/2014

ROULAND XAVIER PASCAL

Consejero
Nombramiento: 30/09/2014

BERTRAND RUIZ DE VELASCO IÑIGO

Consejero
Nombramiento: 30/09/2014

CABRERA MENDEZ GERMAN FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 30/09/2014

ROULAND XAVIER PASCAL

Vicepresidente
Nombramiento: 30/09/2014

ROULAND XAVIER PASCAL

Consejero delegado
Nombramiento: 28/08/2013

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 21/08/2013

RIQUELME BUSTILLO LAETITIA

Consejero
Cese: 21/08/2013

RIQUELME BUSTILLO LAETITIA

Secretario
Nombramiento: 21/08/2013

BILBAO GARAY ANE

Secretario no consejero
Nombramiento: 03/10/2012

MARTIN PEDERIVA PATRICIA ELIDA

Apoderado
Nombramiento: 03/10/2012

VERDE MILICUA OSCAR

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by POWER SUPPORT SL

04/04/2016 Details of the advert (146389) Registry data: T 32658 , F 102, S 8, H M 399829, I/A 28 (23.03.16).

  • Cambio de denominación social

    EDF FENICE SERVICES IBERICA SL.

04/04/2016 Details of the advert (146388) Registry data: T 32658 , F 102, S 8, H M 399829, I/A 27 (23.03.16).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

29/07/2015 Details of the advert (314533) Registry data: T 32658 , F 102, S 8, H M 399829, I/A 26 (20.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: ROULAND XAVIER PASCAL.

  • Nombramientos

    Representan: GIL NUÑO ANA.

16/02/2015 Details of the advert (67634) Registry data: T 32658 , F 101, S 8, H M 399829, I/A 25 ( 5.02.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BROUCHON JEAN JOLYOT;BERTRAND RUIZ DE VELASCO IÑIGO;CABRERA MENDEZ GERMAN FERNANDO;KATCHAROV NICOLAS ANTONY;ROULAND XAVIER PASCAL;MARITANO MIRCO. SecreNoConsj: BILBAO GARAY ANE. Presidente: KATCHAROV NICOLAS ANTONY. Vicepresid.: ROULAND XAVIER PASCAL. Con.Delegado: ROULAND XAVIER PASCAL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: FENICE INSTALACIONES IBERICA SL. Representan: ROULAND XAVIER PASCAL.

  • Modificaciones Estatutarias

    22 Y 23.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

27/11/2014 Details of the advert (484049) Registry data: T 32658 , F 101, S 8, H M 399829, I/A 24 (18.11.14).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    FENICE INSTALACIONES IBERICA SL.

06/11/2014 Details of the advert (448506) Registry data: T 32658 , F 101, S 8, H M 399829, I/A 23 (30.10.14).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

03/10/2014 Details of the advert (395357) Registry data: T 32658 , F 100, S 8, H M 399829, I/A 22 (25.09.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: MARTINEZ DIAZ SUSANA.

30/09/2014 Details of the advert (388297) Registry data: T 22388 , F 206, S 8, H M 399829, I/A 21 (22.09.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GAY PASCAL MAURICE RENE.

  • Nombramientos

    Consejero: MARITANO MIRCO.

  • Reelecciones

    Consejero: ROULAND XAVIER PASCAL;BERTRAND RUIZ DE VELASCO IÑIGO;CABRERA MENDEZ GERMAN FERNANDO. Vicepresid.: ROULAND XAVIER PASCAL. Con.Delegado: ROULAND XAVIER PASCAL.

28/08/2013 Details of the advert (378695) Registry data: T 22388 , F 206, S 8, H M 399829, I/A 20 (20.08.13).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

21/08/2013 Details of the advert (371221) Registry data: T 22388 , F 206, S 8, H M 399829, I/A 19 (12.08.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: RIQUELME BUSTILLO LAETITIA. Secretario: RIQUELME BUSTILLO LAETITIA.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: BILBAO GARAY ANE.

Mercantile Registry documents related: 28

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-63-28 04/04/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-63-28 04/04/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-142-28 29/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-31-28 16/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-227-28 27/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-213-28 06/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-189-28 03/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-186-28 30/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-163-28 28/08/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-158-28 21/08/2013 Madrid Descargar