POITIERS DEVELOPS SL

Cambio de denominación social

C/ FERNANDEZ DE LA HOZ ( 24MADRID).
-
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 01/08/2012

CIRIA SUAREZ HECTOR

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 01/08/2012

MADERA NUÑEZ VICTOR

Consejero
Nombramiento: 21/12/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SARL

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA S AR L

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SARL

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

FERNANDEZ VALMAYOR ADOLFO JESUS

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2011

MON GARCIA JORGE

Apoderado
Nombramiento: 02/11/2011

SALGADO HERRERA JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2011

MON GARCIA JORGE

Apoderado solidario
Nombramiento: 20/07/2011

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 20/07/2011

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 20/07/2011

DELOITTE SL

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 20/07/2011

DELOITTE SL

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 26/04/2011

BORRERO ZORITA LUIS

Apoderado
Nombramiento: 26/04/2011

LARDIES NOGALES SANTIAGO

Apoderado
Nombramiento: 26/04/2011

LUCAS CALDERON EDUARDO

Apoderado
Nombramiento: 26/04/2011

GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 24/02/2011

BORRERO ZORITA LUIS

Apoderado
Nombramiento: 24/02/2011

LARDIES NOGALES SANTIAGO

Apoderado
Nombramiento: 24/02/2011

LUCAS CALDERON EDUARDO

Apoderado
Nombramiento: 24/02/2011

GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO

Apoderado
Cese: 09/02/2011

PICON GARCIA DE LEANIZ JUAN

Administrador único
Nombramiento: 09/02/2011

COBO BACHILLER IGNACIO

Representante
Nombramiento: 09/02/2011

DE JAIME GUIJARRO FRANCISCO JAVIER

Representante
Nombramiento: 09/02/2011

COSTI RUIZ PABLO JULIAN

Representante
Nombramiento: 09/02/2011

PICON GARCIA DE LEANIZ JUAN

Secretario no consejero
Nombramiento: 09/02/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SARL

Consejero
Nombramiento: 09/02/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SARL

Consejero
Nombramiento: 09/02/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SARL

Consejero
Nombramiento: 09/02/2011

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SARL

Presidente
Cese: 30/12/2010

PEREZ GOMEZ ROSARIO

Administrador único
Nombramiento: 30/12/2010

PICON GARCIA DE LEANIZ JUAN

Administrador único
Nombramiento: 07/12/2010

PEREZ GOMEZ ROSARIO

Administrador único

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by POITIERS DEVELOPS SL

15/01/2013 Details of the advert (18078) Registry data: T 29074 , F 146, S 8, H M 509015, I/A 20 ( 4.01.13).

  • Cambio de denominación social

    CAPIO SANIDAD HOLDING SL.

01/08/2012 Details of the advert (323395) Registry data: T 29074 , F 144, S 8, H M 509015, I/A 19 (20.07.12).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: CIRIA SUAREZ HECTOR.

01/08/2012 Details of the advert (323394) Registry data: T 29074 , F 144, S 8, H M 509015, I/A 18 (20.07.12).

  • Cambio de domicilio social

    C/ FERNANDEZ DE LA HOZ ( 24MADRID).

01/08/2012 Details of the advert (323393) Registry data: T 29074 , F 144, S 8, H M 509015, I/A 17 (20.07.12).

  • Nombramientos

    Consejero: MADERA NUÑEZ VICTOR.

19/01/2012 Details of the advert (26535) Registry data: T 29074 , F 143, S 8, H M 509015, I/A 16 (10.01.12).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 31.518.921,00 Euros.

19/01/2012 Details of the advert (26534) Registry data: T 29074 , F 143, S 8, H M 509015, I/A 15 (10.01.12).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    HC INVESTMENTS BV.

29/12/2011 Details of the advert (521596) Registry data: T 29074 , F 142, S 8, H M 509015, I/A 14 (19.12.11).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: SE MODIFICA EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS POR CAMBIO DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL..

21/12/2011 Details of the advert (508236) Registry data: T 29074 , F 136, S 8, H M 509015, I/A 13 ( 7.12.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SARL;THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA S AR L;THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SARL;FERNANDEZ VALMAYOR ADOLFO JESUS;GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS;MON GARCIA JORGE.

20/12/2011 Details of the advert (504175) Registry data: T 28260 , F 159, S 8, H M 509015, I/A 12 ( 5.12.11).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 4.130.815,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.518.921,00 Euros.

17/11/2011 Details of the advert (455274) Registry data: T 28260 , F 158, S 8, H M 509015, I/A 11 ( 7.11.11).

  • Pérdida del carácter de unipersonalidad

Mercantile Registry documents related: 20

#CVE
Date
State
BORME-A-2013-9-28 15/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-146-28 01/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-146-28 01/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-146-28 01/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-13-28 19/01/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-13-28 19/01/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-246-28 29/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-240-28 21/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-239-28 20/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-218-28 17/11/2011 Madrid Descargar