PARQUE FOTOVOLTAICO DON ALVARO CATORCE SL

Extinta

PASEO DE LA CASTELLANA 91 11 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 28/05/2024

FIDALGO VENTURA DA SILVA BRANDAO MARIA HELENA

Apoderado mancomunado
Cese: 28/05/2024

LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO

Apoderado mancomunado
Cese: 28/05/2024

LOPEZ PAZ RUBEN-ALBERTO

Apoderado
Cese: 07/04/2020

BARAHONA ESTEBAN PABLO

Representante
Nombramiento: 07/04/2020

JAQUETE PASTOR JUAN

Representante
Cese: 08/11/2019

ABREU BECA PEREIRA DA CUNHA JOSE VALENTIM

Administrador mancomunado
Cese: 08/11/2019

DA SILVA CARDOSO CARLOS- MANUEL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 08/11/2019

SONDASOL SPAIN SL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 08/11/2019

EOLICA DE MALAGA SL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 27/02/2018

LOPEZ PAZ RUBEN-ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 29/04/2009

FIDALGO VENTURA DA SILVA BRANDAO MARIA HELENA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 29/04/2009

LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO

Apoderado mancomunado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by PARQUE FOTOVOLTAICO DON ALVARO CATORCE SL

31/10/2024 Details of the advert (466212) Registry data: S 8 , H M 708622, I/A 5 (24.10.24).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

28/05/2024 Details of the advert (241013) Registry data: S 8 , H M 708622, I/A 4 (21.05.24).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: FIDALGO VENTURA DA SILVA BRANDAO MARIA HELENA;LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO. Apoderado: LOPEZ PAZ RUBEN-ALBERTO.

07/04/2020 Details of the advert (140862) Registry data: T 39897 , F 168, S 8, H M 708622, I/A 3 (31.03.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: BARAHONA ESTEBAN PABLO.

  • Nombramientos

    Representan: JAQUETE PASTOR JUAN.

12/12/2019 Details of the advert (511349) Registry data: T 39897 , F 164, S 8, H M 708622, I/A 2 ( 3.12.19).

  • Cambio de domicilio social

    PASEO DE LA CASTELLANA 91 11 (MADRID).

08/11/2019 Details of the advert (463213) Registry data: T 3512, L 3512, F 132, S 8, H PO 47082, I/A 6 (30.10.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: ABREU BECA PEREIRA DA CUNHA JOSE VALENTIM;DA SILVA CARDOSO CARLOS- MANUEL.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: SONDASOL SPAIN SL;EOLICA DE MALAGA SL.

  • Cambio de objeto social

    a) La promoción, gestión, diseño, construcción, explotación, operación y mantenimiento de instalaciones destinadas a la producción de energía, entre otras, pero sin limitarse a, energías renovables. La producción, venta y/o explotación de energía generada por las instalaciones indicadas y, en su cas.

27/02/2018 Details of the advert (94080) Registry data: T 3512, L 3512, F 132, S 8, H PO 47082, I/A 5 (19.02.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: LOPEZ PAZ RUBEN-ALBERTO.

10/01/2013 Details of the advert (11187) Registry data: T 3512, L 3512, F 132, S 8, H PO 47082, I/A 4 (27.12.12).

  • Cambio de domicilio social

    C/ COLON 29 4 D& (VIGO).

26/09/2011 Details of the advert (623043)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

07/06/2011 Details of the advert (167109)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2011) Año: 2009

29/05/2009 Details of the advert (136253)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 11

#CVE
Date
State
BORME-A-2024-211-28 31/10/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2024-101-28 28/05/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2020-68-28 07/04/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-237-28 12/12/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-215-36 08/11/2019 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-41-36 27/02/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2013-6-36 10/01/2013 Pontevedra Descargar
BORME-B-2011-183-36 26/09/2011 Pontevedra Descargar
BORME-B-2011-108-36 07/06/2011 Pontevedra Descargar
BORME-B-2009-100-36 29/05/2009 Pontevedra Descargar