PACE IBERIA SL

Extinta

C/ MARTINEZ VILLERGAS 52 - BLOQUE 3 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 24/01/2019

GUAGLIANONE PABLO DIEGO

Administrador único
Nombramiento: 24/01/2019

GUAGLIANONE PABLO DIEGO

Liquidador
Nombramiento: 08/05/2017

RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP

Apoderado
Nombramiento: 23/01/2017

HUGHES RICHARD GARETH

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/01/2017

HIRST HANNAH

Apoderado solidario
Cese: 26/04/2016

DIXON ANTHONY JOHN

Administrador único
Cese: 26/04/2016

DIXON ANTHONY JOHN

Apoderado
Cese: 26/04/2016

DE LA VIUDA VILLANUEVA JIMENA

Apoderado solidario
Cese: 26/04/2016

LOPEZ DE CARRIZOSA MORA FIGUEROA NICOLAS

Apoderado solidario
Cese: 26/04/2016

ZUBIRI AZCARATE DANIEL

Apoderado solidario
Cese: 26/04/2016

ARIZAGA MAYO RUTH

Apoderado solidario
Cese: 26/04/2016

CESAR MARTINEZ ORIOL

Apoderado solidario
Nombramiento: 26/04/2016

GUAGLIANONE PABLO DIEGO

Administrador único
Nombramiento: 20/11/2014

HAGUE GARETH RICHARD

Apoderado solidario
Nombramiento: 20/11/2014

BIDAUT GILLES

Apoderado solidario
Nombramiento: 07/11/2013

HUGHES RICHARD GARETH

Apoderado
Cese: 11/10/2013

DIXON ANTHONY JOHN

Administrador solidario
Cese: 11/10/2013

WILKINSON DAMIEN MICHAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 11/10/2013

DIXON ANTHONY JOHN

Administrador único
Nombramiento: 21/06/2013

STORY CHRISTOPHER

Apoderado
Nombramiento: 02/11/2010

MANCA DIAZ PATRICIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

SANZ FERRE ENRIQUE

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

DE LA VIUDA VILLANUEVA JIMENA

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

LOPEZ DE CARRIZOSA MORA FIGUEROA NICOLAS

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

ZUBIRI AZCARATE DANIEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

ARIZAGA MAYO RUTH

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

DON CESAR MARTINEZ ORIOL

Apoderado solidario
Nombramiento: 12/04/2010

KPMG AUDITORES SL

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by PACE IBERIA SL

24/01/2019 Details of the advert (32631) Registry data: T 24888 , F 169, S 8, H M 448058, I/A 19 (17.01.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GUAGLIANONE PABLO DIEGO.

  • Nombramientos

    Liquidador: GUAGLIANONE PABLO DIEGO.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

08/05/2017 Details of the advert (191279) Registry data: T 24888 , F 169, S 8, H M 448058, I/A 18 (26.04.17).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP.

08/05/2017 Details of the advert (191278) Registry data: T 24888 , F 169, S 8, H M 448058, I/A 17 (26.04.17).

  • Cambio de domicilio social

    C/ MARTINEZ VILLERGAS 52 - BLOQUE 3 (MADRID).

23/01/2017 Details of the advert (33695) Registry data: T 24888 , F 169, S 8, H M 448058, I/A 16 (13.01.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: HUGHES RICHARD GARETH;HIRST HANNAH.

26/04/2016 Details of the advert (180893) Registry data: T 24888 , F 168, S 8, H M 448058, I/A 15 (18.04.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: DIXON ANTHONY JOHN.

  • Revocaciones

    Apoderado: DIXON ANTHONY JOHN. Apo.Sol.: DE LA VIUDA VILLANUEVA JIMENA;LOPEZ DE CARRIZOSA MORA FIGUEROA NICOLAS;ZUBIRI AZCARATE DANIEL;ARIZAGA MAYO RUTH;CESAR MARTINEZ ORIOL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GUAGLIANONE PABLO DIEGO.

20/11/2014 Details of the advert (473836) Registry data: T 24888 , F 168, S 8, H M 448058, I/A 14 (12.11.14).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: HAGUE GARETH RICHARD;BIDAUT GILLES.

07/11/2013 Details of the advert (475482) Registry data: T 24888 , F 168, S 8, H M 448058, I/A 13 (29.10.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: HUGHES RICHARD GARETH.

11/10/2013 Details of the advert (437115) Registry data: T 24888 , F 167, S 8, H M 448058, I/A 12 ( 3.10.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: DIXON ANTHONY JOHN;WILKINSON DAMIEN MICHAEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: DIXON ANTHONY JOHN.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.

21/06/2013 Details of the advert (284839) Registry data: T 24888 , F 167, S 8, H M 448058, I/A 11 (12.06.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: STORY CHRISTOPHER.

08/06/2011 Details of the advert (167744)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2011) Año: 2009

Mercantile Registry documents related: 14

#CVE
Date
State
BORME-A-2019-16-28 24/01/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2017-85-28 08/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-85-28 08/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-15-28 23/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-79-28 26/04/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-222-28 20/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-213-28 07/11/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-195-28 11/10/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-116-28 21/06/2013 Madrid Descargar
BORME-B-2011-109-28 08/06/2011 Madrid Descargar