ONEWORLD PACKAGING SL

Cambio de denominación social

CARRETERA SEGOVIA (KM 19.6), 601
 Aldeamayor de San Martín, Valladolid  (47162)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 18/12/2018

RODRIGUEZ DIAZ NICOLAS

Secretario no consejero
Nombramiento: 18/12/2018

BAYGUAL DAVOUST FRANCESC A

Secretario no consejero
Cese: 27/06/2018

CEREZO MONTAÑEZ SEBASTIAN

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 18/01/2018

FEVRE OBARRIO PHILLIPE LOUIS

Consejero
Nombramiento: 18/01/2018

FEVRE OBARRIO PHILLIPE LOUIS

Consejero delegado
Nombramiento: 14/09/2017

FEVRE OBARRIO PHILLIPE LOUIS

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 20/07/2017

GONZALEZ GARCIA ANGEL CARLOS

Apoderado
Cese: 15/07/2015

ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO

Consejero delegado
Cese: 15/07/2015

IZQUIERDO DIEGO LUIS CARLOS

Consejero
Cese: 15/07/2015

GONZALEZ MAESTRO CARLOS

Consejero
Cese: 15/07/2015

ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 15/07/2015

ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO

Apoderado solidario
Cese: 08/06/2015

MARTIN-CALAMA PRIETO MIGUEL

Secretario no consejero
Nombramiento: 08/06/2015

RODRIGUEZ DIAZ NICOLAS

Secretario no consejero
Nombramiento: 31/03/2015

CEREZO MONTAÑEZ SEBASTIAN

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 31/03/2015

MATA MAYRAND ALVARO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 20/02/2014

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 04/10/2013

GROTH OLE

Presidente
Nombramiento: 04/10/2013

RUEDA HERNANDO MIGUEL

Presidente

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by ONEWORLD PACKAGING SL

16/05/2019 Details of the advert (207205) Registry data: T 1514 , F 224, S 8, H VA 25683, I/A 22 ( 8.05.19).

  • Cambio de denominación social

    PACKBENEFIT SL.

18/12/2018 Details of the advert (506317) Registry data: T 1514 , F 224, S 8, H VA 25683, I/A 21 (11.12.18).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: RODRIGUEZ DIAZ NICOLAS.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: BAYGUAL DAVOUST FRANCESC A.

27/06/2018 Details of the advert (270554) Registry data: T 1514 , F 224, S 8, H VA 25683, I/A 20 (20.06.18).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: CEREZO MONTAÑEZ SEBASTIAN.

18/01/2018 Details of the advert (28127) Registry data: T 1514 , F 224, S 8, H VA 25683, I/A 19 (11.01.18).

  • Nombramientos

    Consejero: FEVRE OBARRIO PHILLIPE LOUIS. Con.Delegado: FEVRE OBARRIO PHILLIPE LOUIS.

14/09/2017 Details of the advert (371518) Registry data: T 1514 , F 223, S 8, H VA 25683, I/A 18 ( 7.09.17).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: FEVRE OBARRIO PHILLIPE LOUIS.

20/07/2017 Details of the advert (299032) Registry data: T 1475 , F 37, S 8, H VA 25683, I/A 17 (14.07.17).

  • Nombramientos

    Apoderado: GONZALEZ GARCIA ANGEL CARLOS.

13/04/2016 Details of the advert (162660) Registry data: T 1475 , F 36, S 8, H VA 25683, I/A 16 ( 6.04.16).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.554.420,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    ARTICULO 11. LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta General de Socios se podrá celebrar en cualquier localidad del territorio nacional. Si en la convocatoria no figurase el lugar concreto de celebración, se entenderá que la Junta General de Socios ha sido convocada para su.

31/07/2015 Details of the advert (320214) Registry data: T 1475 , F 36, S 8, H VA 25683, I/A 15 (24.07.15).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.492.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.554.420,00 Euros.

15/07/2015 Details of the advert (291479) Registry data: T 1475 , F 35, S 8, H VA 25683, I/A 13 ( 8.07.15).

  • Otros Conceptos

    Modificación de los artículos 14, 17, 19, 20 y 23 de los Estatutos Sociales.

15/07/2015 Details of the advert (291480) Registry data: T 1475 , F 36, S 8, H VA 25683, I/A 14 ( 8.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO. Consejero: IZQUIERDO DIEGO LUIS CARLOS;GONZALEZ MAESTRO CARLOS;ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO.

Mercantile Registry documents related: 20

#CVE
Date
State
BORME-A-2019-91-47 16/05/2019 Valladolid Descargar
BORME-A-2018-241-47 18/12/2018 Valladolid Descargar
BORME-A-2018-122-47 27/06/2018 Valladolid Descargar
BORME-A-2018-13-47 18/01/2018 Valladolid Descargar
BORME-A-2017-176-47 14/09/2017 Valladolid Descargar
BORME-A-2017-137-47 20/07/2017 Valladolid Descargar
BORME-A-2016-70-47 13/04/2016 Valladolid Descargar
BORME-A-2015-144-47 31/07/2015 Valladolid Descargar
BORME-A-2015-132-47 15/07/2015 Valladolid Descargar
BORME-A-2015-132-47 15/07/2015 Valladolid Descargar