OCIO FACTORY TIME SL

Situación Concursal

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 31/08/2018

PEREZ DOLSET JAVIER

Representante
Cese: 31/08/2018

ZED WORLDWIDE SA EN LIQUIDACION

Administrador único
Nombramiento: 31/08/2018

ALBIOL PLANS JORDI

Representante
Nombramiento: 01/04/2015

ORUSCO MANCHON EDUARDO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 24/12/2014

ARTEAGA GARCIA DANIEL

Apoderado solidario
Cese: 24/12/2014

ARTEAGA GARCIA DANIEL

Apoderado
Cese: 04/12/2014

CEBRIAN GARCIA BALLESTEROS GONZALO MARIA

Apoderado
Cese: 04/12/2014

ALVAREZ DE TOLEDO MENDEZ DE VIGO IÑIGO

Apoderado
Nombramiento: 20/10/2014

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 22/11/2012

CAMACHO CAMACHO ANA ROSA

Apoderado
Cese: 22/11/2012

DE MIGUEL GUIJARRO ANA MARIA

Apoderado
Cese: 22/11/2012

GAMAZO DE ROUX GABRIEL JOSE

Apoderado
Cese: 20/06/2012

MORA VEGA JUAN FRANCISCO

Apoderado
Cese: 20/06/2012

LOPEZ DE ARAGON LOPEZ VERONICA

Apoderado
Nombramiento: 20/06/2012

ALVAREZ DE TOLEDO MENDEZ DE VIGO IÑIGO

Apoderado
Nombramiento: 17/10/2011

ROMERO ALONSO FRANCISCO

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by OCIO FACTORY TIME SL

26/06/2023 Details of the advert (288069) Registry data: T 28024 , F 112, S 8, H M 456601, I/A 27 (19.06.23).

  • Otros Conceptos

    se acumula el concurso al procedimiento 503/2018 del Juzgado de lo Mwercantil 11 de Madrid.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 503/2018. FIRME: Si, Fecha de resolución 17/10/2016. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID. Juez: TERESA VAZQUEZ PIZARRO.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 503/2018. Fecha de resolución 17/10/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: TERESA VAZQUEZ PIZARRO. Administrador Concursal. Fecha 17/10/2016, NIF/CIF B65216517. ROUSAUD COSTAS DURAN CONCURSAL SLP.

07/12/2022 Details of the advert (535708) Registry data: T 28024 , F 112, S 8, H M 456601, I/A C (29.11.22).

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 503/2018. FIRME: No, Fecha de resolución 21/06/2018. Auto de aprobación del plan de liquidación. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID. Juez: CARMEN GONZALEZ SUAREZ. Resoluciones: Mandamiento expedido el día 21.06.18 ordenando la anotación preventiva de la aprobación del plan de liquidación y apertura de la sección sexta, según se acuerda en auto de misma fecha.

31/08/2018 Details of the advert (358322) Registry data: T 28024 , F 111, S 8, H M 456601, I/A B (15.08.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: PEREZ DOLSET JAVIER. Adm. Unico: ZED WORLDWIDE SA EN LIQUIDACION.

  • Nombramientos

    Representan: ALBIOL PLANS JORDI.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 470/2016. FIRME: No, Fecha de resolución 14/07/2017. Auto de apertura de la fase de liquidación. Juzgado: num. 9 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: TERESA VAZQUEZ PIZARRO. Resoluciones: AUTO DICTADO EL 14/07/2017, POR EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 9 DE MADRID, PROCEDIMIENTO 470/20165, DECLARANDO LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, CESANDO EL ADMINISTRADOR QUE SERA SUSTITUIDO POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 470/2016. Fecha de resolución 13/03/2018. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 9 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: TERESA VAZQUEZ PIZARRO. Administrador Concursal. Fecha 13/03/2018, NIF/CIF B65216517. ROUSAUD COSTAS DURAN CONCURSAL SLP.

  • Disolución

    Otras Causas.

16/05/2017 Details of the advert (201943) Registry data: T 28024 , F 111, S 8, H M 456601, I/A A ( 5.05.17).

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 470/2016. FIRME: No, Fecha de resolución 17/10/2016. Solicitud de declaración. Juzgado: num. 9 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: TERESA VAZQUEZ PIZARRO. Resoluciones: Mandamiento expedido el día 17.10.2017 en el que se ordena la anotación preventiva de concurso de carácter voluntario según lo acordado enl auto de la misma fecha que se transcribe literalmente.

01/04/2015 Details of the advert (139511) Registry data: T 28024 , F 109, S 8, H M 456601, I/A 26 (24.03.15).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: ORUSCO MANCHON EDUARDO.

24/12/2014 Details of the advert (525750) Registry data: T 28024 , F 109, S 8, H M 456601, I/A 25 (16.12.14).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: ARTEAGA GARCIA DANIEL. Apoderado: ARTEAGA GARCIA DANIEL.

04/12/2014 Details of the advert (496648) Registry data: T 28024 , F 108, S 8, H M 456601, I/A 24 (26.11.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: CEBRIAN GARCIA BALLESTEROS GONZALO MARIA;ALVAREZ DE TOLEDO MENDEZ DE VIGO IÑIGO.

20/10/2014 Details of the advert (418940) Registry data: T 28024 , F 108, S 8, H M 456601, I/A 23 (10.10.14).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

22/11/2012 Details of the advert (481058) Registry data: T 28024 , F 106, S 8, H M 456601, I/A 22 (12.11.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: CAMACHO CAMACHO ANA ROSA.

22/11/2012 Details of the advert (481057) Registry data: T 28024 , F 106, S 8, H M 456601, I/A 21 (12.11.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: DE MIGUEL GUIJARRO ANA MARIA;GAMAZO DE ROUX GABRIEL JOSE.

Mercantile Registry documents related: 17

#CVE
Date
State
BORME-A-2023-119-28 26/06/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-232-28 07/12/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2018-168-28 31/08/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-90-28 16/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2015-62-28 01/04/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-245-28 24/12/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-232-28 04/12/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-200-28 20/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2012-224-28 22/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-224-28 22/11/2012 Madrid Descargar