NMAS1 SYZ GESTION S G I I C SA

Cambio de denominación social

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 31/10/2016

LLANZA FIGUEROA JACOBO

Consejero
Cese: 31/10/2016

BEDAT PATRICK

Consejero
Cese: 31/10/2016

GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO

Consejero
Cese: 31/10/2016

SYZ ERIC

Consejero
Cese: 31/10/2016

SYZ ERIC

Presidente
Nombramiento: 31/10/2016

GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

LLANZA FIGUEROA JACOBO

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

DE CACERES CABRERO FRANCISCO IGNACIO

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

MARCO-GARDOQUI ALCALA-GALIANO IÑIGO

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO

Presidente
Nombramiento: 08/06/2016

GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO

Consejero
Nombramiento: 08/06/2016

SYZ ERIC

Consejero
Nombramiento: 08/06/2016

SYZ ERIC

Presidente
Cese: 04/12/2015

GUILLON XAVIER

Consejero
Nombramiento: 04/12/2015

BEDAT PATRICK

Consejero
Nombramiento: 18/06/2015

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 20/05/2015

BOULGARIS NICOLAS

Consejero
Nombramiento: 20/05/2015

GUILLON XAVIER

Consejero
Cese: 05/03/2013

DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IGNACIO

Apoderado
Cese: 05/03/2013

VALVERDE VAQUERO ALEJANDRA

Apoderado
Nombramiento: 05/03/2013

VALVERDE VAQUERO ALEJANDRA

Apoderado
Nombramiento: 05/03/2013

DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 09/10/2012

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 26/09/2011

PEREZ FERNANDEZ ROSA MARIA

Apoderado
Cese: 26/09/2011

PEREZ FERNANDEZ ROSA MARIA

Apoderado
Cese: 26/09/2011

ALTAREJOS JIMENEZ LUIS

Apoderado
Nombramiento: 26/09/2011

DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 26/09/2011

VALVERDE VAQUERO ALEJANDRA

Apoderado
Nombramiento: 26/09/2011

DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IGNACIO

Apoderado
Cese: 16/03/2011

DEL RIO GALAN JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 16/03/2011

LLANZA FIGUEROA JACOBO

Consejero
Cese: 08/03/2011

ALBELLA AMIGO FRANCISCO

Apoderado mancomunado
Cese: 08/03/2011

DEL RIO GALAN JOSE LUIS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 08/03/2011

ALBELLA AMIGO FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 08/03/2011

GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by NMAS1 SYZ GESTION S G I I C SA

31/10/2016 Details of the advert (438851) Registry data: T 28802 , F 176, S 8, H M 358562, I/A 39 (21.10.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LLANZA FIGUEROA JACOBO;BEDAT PATRICK;GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO;SYZ ERIC. Presidente: SYZ ERIC.

  • Nombramientos

    Consejero: GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO;LLANZA FIGUEROA JACOBO;DE CACERES CABRERO FRANCISCO IGNACIO;MARCO-GARDOQUI ALCALA-GALIANO IÑIGO. Presidente: GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO.

  • Modificaciones Estatutarias

    Se modifican los artículos 1 , 7 , 8 , 10 , 11 , 14 , 20 , 21 , 23 , 26 , 29 y 36 de los Estatutos Sociales..

  • Cambio de denominación social

    ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION SGIIC SA.

08/06/2016 Details of the advert (242856) Registry data: T 28802 , F 176, S 8, H M 358562, I/A 38 ( 1.06.16).

  • Reelecciones

    Consejero: GIL IÑIGUEZ DE HEREDIA ALFONSO;SYZ ERIC. Presidente: SYZ ERIC.

03/03/2016 Details of the advert (100856) Registry data: T 28802 , F 175, S 8, H M 358562, I/A 37 (24.02.16).

  • Cambio de objeto social

    Las actividades permitidas a las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva por el artículo 40 de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

04/12/2015 Details of the advert (493795) Registry data: T 28802 , F 175, S 8, H M 358562, I/A 36 (26.11.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GUILLON XAVIER.

  • Nombramientos

    Consejero: BEDAT PATRICK.

07/07/2015 Details of the advert (277563) Registry data: T 28802 , F 174, S 8, H M 358562, I/A 35 (29.06.15).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 11.570,00 Euros. Desembolsado: 11.570,00 Euros. Resultante Suscrito: 543.484,00 Euros. Resultante Desembolsado: 543.484,00 Euros.

18/06/2015 Details of the advert (248007) Registry data: T 28802 , F 174, S 8, H M 358562, I/A 34 (10.06.15).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

20/05/2015 Details of the advert (202619) Registry data: T 28802 , F 174, S 8, H M 358562, I/A 33 (12.05.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BOULGARIS NICOLAS.

  • Nombramientos

    Consejero: GUILLON XAVIER.

21/05/2014 Details of the advert (212195) Registry data: T 28802 , F 171, S 8, H M 358562, I/A 32 (13.05.14).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 31.914,00 Euros. Desembolsado: 31.914,00 Euros. Resultante Suscrito: 531.914,00 Euros. Resultante Desembolsado: 531.914,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 7 Y 15 Y SE CREA UN NUEVO ARTICULO 7 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..

02/04/2014 Details of the advert (147319) Registry data: T 28802 , F 171, S 8, H M 358562, I/A 31 (25.03.14).

  • Página web de la sociedad

    Creación de la página web corporativa: www.nmas1syz.com.

05/03/2013 Details of the advert (108970) Registry data: T 28802 , F 170, S 8, H M 358562, I/A 30 (25.02.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IGNACIO;VALVERDE VAQUERO ALEJANDRA.

  • Nombramientos

    Apoderado: VALVERDE VAQUERO ALEJANDRA;DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IGNACIO.

Mercantile Registry documents related: 18

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-208-28 31/10/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-108-28 08/06/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-43-28 03/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-232-28 04/12/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-126-28 07/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-113-28 18/06/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-93-28 20/05/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-94-28 21/05/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-64-28 02/04/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-44-28 05/03/2013 Madrid Descargar