N C MEPRO SA
Extinta
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 01/02/2016 | VIRYASOV ALEXANDER |
Consejero |
| Cese: 01/02/2016 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Apoderado |
| Cese: 01/02/2016 | RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA |
Apoderado |
| Cese: 22/07/2015 | MEPRO OUTREMER SL |
Presidente |
| Nombramiento: 22/07/2015 | NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 22/07/2015 | NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE |
Presidente |
| Nombramiento: 22/07/2015 | MEPRO OUTREMER SL |
Consejero |
| Nombramiento: 22/07/2015 | NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA |
Consejero |
| Nombramiento: 22/07/2015 | VIRYASOV ALEXANDER |
Consejero |
| Nombramiento: 22/07/2015 | NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA |
Secretario |
| Nombramiento: 18/08/2014 | NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE IGNACIO |
Representante |
| Nombramiento: 18/08/2014 | MEPRO OUTREMER SL |
Consejero |
| Nombramiento: 18/08/2014 | MEPRO OUTREMER SL |
Presidente |
| Nombramiento: 18/08/2014 | NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA |
Consejero |
| Nombramiento: 18/08/2014 | NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA |
Secretario |
| Nombramiento: 18/08/2014 | VIRYASOV ALEXANDER |
Consejero |
| Nombramiento: 27/06/2013 | RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA |
Apoderado |
| Cese: 27/06/2013 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 27/06/2013 | MARQUEZ RUIZ RICARDO |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 27/06/2013 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Apoderado |
| Nombramiento: 27/06/2013 | RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA |
Apoderado |
| Cese: 11/05/2012 | DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 11/05/2012 | MARQUEZ RUIZ RICARDO |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 11/05/2012 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 11/05/2012 | MARQUEZ RUIZ RICARDO |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 29/03/2012 | DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL |
Consejero |
| Nombramiento: 29/03/2012 | VIRIASSOV ALEJANDRO |
Consejero |
| Nombramiento: 07/12/2010 | NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE IGNACIO |
Apoderado |
| Cese: 08/09/2010 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Consejero |
| Nombramiento: 08/09/2010 | DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL |
Consejero |
| Cese: 07/09/2010 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Apoderado |
| Cese: 07/09/2010 | VIRIASSOV ALEXANDRE |
Apoderado |
| Cese: 07/09/2010 | MARQUEZ RUIZ RICARDO |
Apoderado |
| Cese: 07/09/2010 | SANCHEZ SEGURA ANGEL |
Apoderado |
| Nombramiento: 07/09/2010 | DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 07/09/2010 | MARQUEZ RUIZ RICARDO |
Apoderado mancomunado |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by N C MEPRO SA
24/01/2017 Details of the advert (36125) Registry data: T 31051 , F 115, S 8, H M 4614, I/A 41 (16.01.17).
- Disolución
Fusion.
- Extinción
25/10/2016 Details of the advert (429771) Registry data: T 31051 , F 115, S 8, H M 4614, I/A 40 (18.10.16).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
MEPRO OUTREMER SL.
01/02/2016 Details of the advert (42053) Registry data: T 31051 , F 115, S 8, H M 4614, I/A 39 (22.01.16).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: VIRYASOV ALEXANDER.
- Revocaciones
Apoderado: VIRIASSOV ALEXANDRE;RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA.
22/07/2015 Details of the advert (303355) Registry data: T 31051 , F 114, S 8, H M 4614, I/A 38 (14.07.15).
- Ceses/Dimisiones
Presidente: MEPRO OUTREMER SL.
- Nombramientos
Consejero: NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE. Presidente: NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE.
- Reelecciones
Consejero: MEPRO OUTREMER SL;NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA;VIRYASOV ALEXANDER. Secretario: NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA.
- Modificaciones Estatutarias
Modificados los artículos 15º y 16º de los estatutos sociales..
18/08/2014 Details of the advert (336321) Registry data: T 31051 , F 113, S 8, H M 4614, I/A 37 ( 8.08.14).
- Reelecciones
Representan: NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE IGNACIO. Consejero: MEPRO OUTREMER SL. Presidente: MEPRO OUTREMER SL. Consejero: NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA. Secretario: NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA. Consejero: VIRYASOV ALEXANDER.
01/08/2013 Details of the advert (345168) Registry data: T 31051 , F 113, S 8, H M 4614, I/A 36 (25.07.13).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 7.891,00 Euros. Resultante Suscrito: 73.244,00 Euros.
27/06/2013 Details of the advert (294315) Registry data: T 31051 , F 113, S 8, H M 4614, I/A 1 (20.06.13).
- Nombramientos
Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA.
27/06/2013 Details of the advert (294314) Registry data: T 9830 , F 211, S 8, H M 4614, I/A 34 (20.06.13).
- Revocaciones
Apo.Manc.: VIRIASSOV ALEXANDRE;MARQUEZ RUIZ RICARDO.
- Nombramientos
Apoderado: VIRIASSOV ALEXANDRE;RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA.
11/05/2012 Details of the advert (203283) Registry data: T 9830 , F 210, S 8, H M 4614, I/A 32 (27.04.12).
- Revocaciones
Apo.Manc.: DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL;MARQUEZ RUIZ RICARDO.
- Nombramientos
Apo.Manc.: VIRIASSOV ALEXANDRE;MARQUEZ RUIZ RICARDO.
29/03/2012 Details of the advert (146236) Registry data: T 9830 , F 209, S 8, H M 4614, I/A 31 (16.03.12).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL.
- Nombramientos
Consejero: VIRIASSOV ALEJANDRO.
Mercantile Registry documents related: 17
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2017-16-28 | 24/01/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-204-28 | 25/10/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-20-28 | 01/02/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-137-28 | 22/07/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-155-28 | 18/08/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-145-28 | 01/08/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-120-28 | 27/06/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-120-28 | 27/06/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-89-28 | 11/05/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-62-28 | 29/03/2012 | Madrid | Descargar |