N C MEPRO SA

Extinta

CALLE VIA DE LAS DOS CASTILLAS, 3
 Pozuelo de Alarcón, Madrid  (28224)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 01/02/2016

VIRYASOV ALEXANDER

Consejero
Cese: 01/02/2016

VIRIASSOV ALEXANDRE

Apoderado
Cese: 01/02/2016

RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA

Apoderado
Cese: 22/07/2015

MEPRO OUTREMER SL

Presidente
Nombramiento: 22/07/2015

NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE

Consejero
Nombramiento: 22/07/2015

NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE

Presidente
Nombramiento: 22/07/2015

MEPRO OUTREMER SL

Consejero
Nombramiento: 22/07/2015

NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA

Consejero
Nombramiento: 22/07/2015

VIRYASOV ALEXANDER

Consejero
Nombramiento: 22/07/2015

NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA

Secretario
Nombramiento: 18/08/2014

NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE IGNACIO

Representante
Nombramiento: 18/08/2014

MEPRO OUTREMER SL

Consejero
Nombramiento: 18/08/2014

MEPRO OUTREMER SL

Presidente
Nombramiento: 18/08/2014

NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA

Consejero
Nombramiento: 18/08/2014

NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA

Secretario
Nombramiento: 18/08/2014

VIRYASOV ALEXANDER

Consejero
Nombramiento: 27/06/2013

RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA

Apoderado
Cese: 27/06/2013

VIRIASSOV ALEXANDRE

Apoderado mancomunado
Cese: 27/06/2013

MARQUEZ RUIZ RICARDO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 27/06/2013

VIRIASSOV ALEXANDRE

Apoderado
Nombramiento: 27/06/2013

RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA

Apoderado
Cese: 11/05/2012

DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado
Cese: 11/05/2012

MARQUEZ RUIZ RICARDO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 11/05/2012

VIRIASSOV ALEXANDRE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 11/05/2012

MARQUEZ RUIZ RICARDO

Apoderado mancomunado
Cese: 29/03/2012

DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL

Consejero
Nombramiento: 29/03/2012

VIRIASSOV ALEJANDRO

Consejero
Nombramiento: 07/12/2010

NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE IGNACIO

Apoderado
Cese: 08/09/2010

VIRIASSOV ALEXANDRE

Consejero
Nombramiento: 08/09/2010

DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL

Consejero
Cese: 07/09/2010

VIRIASSOV ALEXANDRE

Apoderado
Cese: 07/09/2010

VIRIASSOV ALEXANDRE

Apoderado
Cese: 07/09/2010

MARQUEZ RUIZ RICARDO

Apoderado
Cese: 07/09/2010

SANCHEZ SEGURA ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 07/09/2010

DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 07/09/2010

MARQUEZ RUIZ RICARDO

Apoderado mancomunado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by N C MEPRO SA

24/01/2017 Details of the advert (36125) Registry data: T 31051 , F 115, S 8, H M 4614, I/A 41 (16.01.17).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

25/10/2016 Details of the advert (429771) Registry data: T 31051 , F 115, S 8, H M 4614, I/A 40 (18.10.16).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    MEPRO OUTREMER SL.

01/02/2016 Details of the advert (42053) Registry data: T 31051 , F 115, S 8, H M 4614, I/A 39 (22.01.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: VIRYASOV ALEXANDER.

  • Revocaciones

    Apoderado: VIRIASSOV ALEXANDRE;RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA.

22/07/2015 Details of the advert (303355) Registry data: T 31051 , F 114, S 8, H M 4614, I/A 38 (14.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: MEPRO OUTREMER SL.

  • Nombramientos

    Consejero: NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE. Presidente: NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE.

  • Reelecciones

    Consejero: MEPRO OUTREMER SL;NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA;VIRYASOV ALEXANDER. Secretario: NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA.

  • Modificaciones Estatutarias

    Modificados los artículos 15º y 16º de los estatutos sociales..

18/08/2014 Details of the advert (336321) Registry data: T 31051 , F 113, S 8, H M 4614, I/A 37 ( 8.08.14).

  • Reelecciones

    Representan: NICOLAS CORREA BARRAGAN JOSE IGNACIO. Consejero: MEPRO OUTREMER SL. Presidente: MEPRO OUTREMER SL. Consejero: NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA. Secretario: NICOLAS CORREA BARRAGAN ANA. Consejero: VIRYASOV ALEXANDER.

01/08/2013 Details of the advert (345168) Registry data: T 31051 , F 113, S 8, H M 4614, I/A 36 (25.07.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 7.891,00 Euros. Resultante Suscrito: 73.244,00 Euros.

27/06/2013 Details of the advert (294315) Registry data: T 31051 , F 113, S 8, H M 4614, I/A 1 (20.06.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA.

27/06/2013 Details of the advert (294314) Registry data: T 9830 , F 211, S 8, H M 4614, I/A 34 (20.06.13).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: VIRIASSOV ALEXANDRE;MARQUEZ RUIZ RICARDO.

  • Nombramientos

    Apoderado: VIRIASSOV ALEXANDRE;RODRIGUEZ GARCIA-ANTON GEMA.

11/05/2012 Details of the advert (203283) Registry data: T 9830 , F 210, S 8, H M 4614, I/A 32 (27.04.12).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL;MARQUEZ RUIZ RICARDO.

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: VIRIASSOV ALEXANDRE;MARQUEZ RUIZ RICARDO.

29/03/2012 Details of the advert (146236) Registry data: T 9830 , F 209, S 8, H M 4614, I/A 31 (16.03.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DE MIGUEL VELASCO MIGUEL ANGEL.

  • Nombramientos

    Consejero: VIRIASSOV ALEJANDRO.

Mercantile Registry documents related: 17

#CVE
Date
State
BORME-A-2017-16-28 24/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-204-28 25/10/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-20-28 01/02/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-137-28 22/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-155-28 18/08/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-145-28 01/08/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-120-28 27/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-120-28 27/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-89-28 11/05/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-62-28 29/03/2012 Madrid Descargar