MINICLIP TECH

Extinta

C/ ALBERTO ALCOCER 46 B 2º A (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 02/09/2016

BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO

Consejero
Cese: 02/09/2016

MARRUGO CAMILO

Consejero
Cese: 02/09/2016

MARRUGO CAMILO

Presidente
Cese: 02/09/2016

CHADWICK BRIAN

Consejero
Cese: 02/09/2016

CHADWICK BRIAN

Secretario
Nombramiento: 02/09/2016

BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO

Liquidador
Cese: 25/09/2014

HINGORANI JEETU LOLITA

Consejero
Cese: 25/09/2014

CHADWICK BRIAN

Secretario no consejero
Nombramiento: 25/09/2014

CHADWICK BRIAN

Consejero
Nombramiento: 25/09/2014

CHADWICK BRIAN

Secretario
Cese: 25/09/2013

GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO

Secretario
Cese: 25/09/2013

MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA

Vicesecretario no consejero
Cese: 25/09/2013

LOGAN ROSS WILLIAN

Consejero
Cese: 25/09/2013

LOGAN ROSS WILLIAN

Presidente
Cese: 25/09/2013

LOGAN ROSS WILLIAN

Consejero delegado
Nombramiento: 25/09/2013

MARRUGO CAMILO

Presidente
Nombramiento: 25/09/2013

HINGORANI JEETU LOLITA

Consejero
Nombramiento: 25/09/2013

CHADWICK BRIAN

Secretario no consejero
Nombramiento: 23/12/2011

BARREDA VELASCO CARLOS

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by MINICLIP TECH

02/09/2016 Details of the advert (363417) Registry data: T 25475 , F 36, S 8, H M 458949, I/A 12 (25.08.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO;MARRUGO CAMILO. Presidente: MARRUGO CAMILO. Consejero: CHADWICK BRIAN. Secretario: CHADWICK BRIAN.

  • Nombramientos

    Liquidador: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

25/09/2014 Details of the advert (382880) Registry data: T 25475 , F 35, S 8, H M 458949, I/A 11 (18.09.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: HINGORANI JEETU LOLITA. SecreNoConsj: CHADWICK BRIAN.

  • Nombramientos

    Consejero: CHADWICK BRIAN. Secretario: CHADWICK BRIAN.

25/09/2013 Details of the advert (411590) Registry data: T 25475 , F 35, S 8, H M 458949, I/A 9 (17.09.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO. VsecrNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA. Consejero: LOGAN ROSS WILLIAN. Presidente: LOGAN ROSS WILLIAN. Con.Delegado: LOGAN ROSS WILLIAN.

  • Nombramientos

    Presidente: MARRUGO CAMILO. Consejero: HINGORANI JEETU LOLITA. SecreNoConsj: CHADWICK BRIAN.

25/09/2013 Details of the advert (411591) Registry data: T 25475 , F 35, S 8, H M 458949, I/A 10 (17.09.13).

  • Cambio de domicilio social

    C/ ALBERTO ALCOCER 46 B 2º A (MADRID).

23/12/2011 Details of the advert (512048) Registry data: T 25475 , F 34, S 8, H M 458949, I/A 8 ( 7.12.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: BARREDA VELASCO CARLOS.

13/12/2011 Details of the advert (494178) Registry data: T 25475 , F 34, S 8, H M 458949, I/A 7 (29.11.11).

  • Cambio de domicilio social

    C/ RIOS ROSAS, NUMERO 36, 2º DERECHA (MADRID).

Mercantile Registry documents related: 6

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-168-28 02/09/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-183-28 25/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-183-28 25/09/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-183-28 25/09/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2011-242-28 23/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-234-28 13/12/2011 Madrid Descargar