MARCH CAMPUS SA

Extinta

CALLE NUÑEZ DE BALBOA, 70 - BIS
Madrid  (28006)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 24/07/2020

CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL

Consejero
Cese: 24/07/2020

DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO

Consejero
Cese: 24/07/2020

DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO

Presidente
Cese: 24/07/2020

NUEVO ALFONSO DAVID

Secretario
Cese: 24/07/2020

NUEVO ALFONSO DAVID

Consejero
Nombramiento: 24/07/2020

BANCA MARCH SA

Liquidador
Nombramiento: 24/07/2020

NUEVO ALFONSO DAVID

Representante
Cese: 14/08/2018

MIJANGOS UGARTE ANA MARIA

Consejero
Cese: 14/08/2018

MIJANGOS UGARTE ANA MARIA

Presidente
Nombramiento: 14/08/2018

DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO

Consejero
Nombramiento: 14/08/2018

DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO

Presidente
Nombramiento: 14/08/2018

NUEVO ALFONSO DAVID

Secretario
Nombramiento: 14/08/2018

NUEVO ALFONSO DAVID

Consejero
Cese: 31/10/2016

ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO

Consejero
Cese: 31/10/2016

ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO

Presidente
Cese: 31/10/2016

CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

MIJANGOS UGARTE ANA MARIA

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL

Consejero
Nombramiento: 31/10/2016

MIJANGOS UGARTE ANA MARIA

Presidente
Nombramiento: 12/09/2014

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 18/09/2012

NUEVO ALFONSO DAVID

Apoderado
Nombramiento: 18/09/2012

NUEVO ALFONSO DAVID

Consejero
Nombramiento: 18/09/2012

ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO

Consejero
Nombramiento: 18/09/2012

CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL

Consejero
Nombramiento: 18/09/2012

ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO

Presidente
Nombramiento: 18/09/2012

NUEVO ALFONSO DAVID

Secretario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by MARCH CAMPUS SA

24/07/2020 Details of the advert (240344) Registry data: T 31018 , F 164, S 8, H M 543039, I/A 19 (17.07.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL;DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Presidente: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Secretario: NUEVO ALFONSO DAVID. Consejero: NUEVO ALFONSO DAVID.

  • Nombramientos

    Liquidador: BANCA MARCH SA. Representan: NUEVO ALFONSO DAVID.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

18/10/2019 Details of the advert (433728) Registry data: T 31018 , F 163, S 8, H M 543039, I/A 18 (11.10.19).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 732.969,10 Euros. Resultante Suscrito: 4.264.337,86 Euros.

14/05/2019 Details of the advert (204014) Registry data: T 31018 , F 161, S 8, H M 543039, I/A 17 ( 7.05.19).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 87.926,15 Euros. Resultante Suscrito: 7.122.148,85 Euros.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 2.124.841,89 Euros. Resultante Suscrito: 4.997.306,96 Euros.

14/08/2018 Details of the advert (337976) Registry data: T 31018 , F 160, S 8, H M 543039, I/A 16 ( 7.08.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA. Presidente: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA.

  • Nombramientos

    Consejero: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Presidente: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO.

  • Reelecciones

    Secretario: NUEVO ALFONSO DAVID. Consejero: NUEVO ALFONSO DAVID.

27/06/2018 Details of the advert (269546) Registry data: T 31018 , F 158, S 8, H M 543039, I/A 15 (18.06.18).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 7.624.925,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.210.075,00 Euros.

31/10/2016 Details of the advert (438789) Registry data: T 31018 , F 158, S 8, H M 543039, I/A 14 (21.10.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO. Presidente: ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO. Consejero: CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL.

  • Nombramientos

    Consejero: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA;CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL. Presidente: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA.

24/12/2015 Details of the advert (522879) Registry data: T 31018 , F 157, S 8, H M 543039, I/A 13 (15.12.15).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 350.000,00 Euros. Desembolsado: 350.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.835.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.835.000,00 Euros.

16/03/2015 Details of the advert (112007) Registry data: T 31018 , F 157, S 8, H M 543039, I/A 11 ( 6.03.15).

  • Otros Conceptos

    Subsanación de la escritura que causó la inscripción 5& de la Hoja social.

12/09/2014 Details of the advert (365018) Registry data: T 31018 , F 156, S 8, H M 543039, I/A 9 ( 4.09.14).

  • Nombramientos

    Auditor: DELOITTE SL.

21/08/2014 Details of the advert (341657) Registry data: T 31018 , F 149, S 8, H M 543039, I/A 8 (12.08.14).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 1.175.000,00 Euros. Desembolsado: 1.175.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.485.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.485.000,00 Euros.

Mercantile Registry documents related: 17

#CVE
Date
State
BORME-A-2020-142-28 24/07/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-201-28 18/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-90-28 14/05/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-156-28 14/08/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-122-28 27/06/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-208-28 31/10/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-245-28 24/12/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-51-28 16/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-174-28 12/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-158-28 21/08/2014 Madrid Descargar