MARCH CAMPUS SA
Extinta
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 24/07/2020 | CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL |
Consejero |
| Cese: 24/07/2020 | DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO |
Consejero |
| Cese: 24/07/2020 | DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO |
Presidente |
| Cese: 24/07/2020 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Secretario |
| Cese: 24/07/2020 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Consejero |
| Nombramiento: 24/07/2020 | BANCA MARCH SA |
Liquidador |
| Nombramiento: 24/07/2020 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Representante |
| Cese: 14/08/2018 | MIJANGOS UGARTE ANA MARIA |
Consejero |
| Cese: 14/08/2018 | MIJANGOS UGARTE ANA MARIA |
Presidente |
| Nombramiento: 14/08/2018 | DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO |
Consejero |
| Nombramiento: 14/08/2018 | DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO |
Presidente |
| Nombramiento: 14/08/2018 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Secretario |
| Nombramiento: 14/08/2018 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Consejero |
| Cese: 31/10/2016 | ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO |
Consejero |
| Cese: 31/10/2016 | ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO |
Presidente |
| Cese: 31/10/2016 | CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL |
Consejero |
| Nombramiento: 31/10/2016 | MIJANGOS UGARTE ANA MARIA |
Consejero |
| Nombramiento: 31/10/2016 | CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL |
Consejero |
| Nombramiento: 31/10/2016 | MIJANGOS UGARTE ANA MARIA |
Presidente |
| Nombramiento: 12/09/2014 | DELOITTE SL |
Auditor |
| Nombramiento: 18/09/2012 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Apoderado |
| Nombramiento: 18/09/2012 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Consejero |
| Nombramiento: 18/09/2012 | ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO |
Consejero |
| Nombramiento: 18/09/2012 | CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL |
Consejero |
| Nombramiento: 18/09/2012 | ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO |
Presidente |
| Nombramiento: 18/09/2012 | NUEVO ALFONSO DAVID |
Secretario |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by MARCH CAMPUS SA
24/07/2020 Details of the advert (240344) Registry data: T 31018 , F 164, S 8, H M 543039, I/A 19 (17.07.20).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL;DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Presidente: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Secretario: NUEVO ALFONSO DAVID. Consejero: NUEVO ALFONSO DAVID.
- Nombramientos
Liquidador: BANCA MARCH SA. Representan: NUEVO ALFONSO DAVID.
- Disolución
Voluntaria.
- Extinción
18/10/2019 Details of the advert (433728) Registry data: T 31018 , F 163, S 8, H M 543039, I/A 18 (11.10.19).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 732.969,10 Euros. Resultante Suscrito: 4.264.337,86 Euros.
14/05/2019 Details of the advert (204014) Registry data: T 31018 , F 161, S 8, H M 543039, I/A 17 ( 7.05.19).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 87.926,15 Euros. Resultante Suscrito: 7.122.148,85 Euros.
- Reducción de Capital
Importe reducción: 2.124.841,89 Euros. Resultante Suscrito: 4.997.306,96 Euros.
14/08/2018 Details of the advert (337976) Registry data: T 31018 , F 160, S 8, H M 543039, I/A 16 ( 7.08.18).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA. Presidente: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA.
- Nombramientos
Consejero: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Presidente: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO.
- Reelecciones
Secretario: NUEVO ALFONSO DAVID. Consejero: NUEVO ALFONSO DAVID.
27/06/2018 Details of the advert (269546) Registry data: T 31018 , F 158, S 8, H M 543039, I/A 15 (18.06.18).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 7.624.925,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.210.075,00 Euros.
31/10/2016 Details of the advert (438789) Registry data: T 31018 , F 158, S 8, H M 543039, I/A 14 (21.10.16).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO. Presidente: ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO. Consejero: CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL.
- Nombramientos
Consejero: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA;CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL. Presidente: MIJANGOS UGARTE ANA MARIA.
24/12/2015 Details of the advert (522879) Registry data: T 31018 , F 157, S 8, H M 543039, I/A 13 (15.12.15).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 350.000,00 Euros. Desembolsado: 350.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.835.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.835.000,00 Euros.
16/03/2015 Details of the advert (112007) Registry data: T 31018 , F 157, S 8, H M 543039, I/A 11 ( 6.03.15).
- Otros Conceptos
Subsanación de la escritura que causó la inscripción 5& de la Hoja social.
12/09/2014 Details of the advert (365018) Registry data: T 31018 , F 156, S 8, H M 543039, I/A 9 ( 4.09.14).
- Nombramientos
Auditor: DELOITTE SL.
21/08/2014 Details of the advert (341657) Registry data: T 31018 , F 149, S 8, H M 543039, I/A 8 (12.08.14).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 1.175.000,00 Euros. Desembolsado: 1.175.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.485.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.485.000,00 Euros.
Mercantile Registry documents related: 17
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2020-142-28 | 24/07/2020 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-201-28 | 18/10/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-90-28 | 14/05/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2018-156-28 | 14/08/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2018-122-28 | 27/06/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-208-28 | 31/10/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-245-28 | 24/12/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-51-28 | 16/03/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-174-28 | 12/09/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-158-28 | 21/08/2014 | Madrid | Descargar |