LABOR DE FIGUERUELAS SL
Activa
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 22/09/2017 | DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL |
Consejero |
| Cese: 22/09/2017 | DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL |
Presidente |
| Cese: 22/09/2017 | DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 16/07/2012 | CORNEJO PABLOS JOSE FERNANDO |
Consejero |
| Cese: 16/07/2012 | MASCARAQUE PEREA LUCIO |
Consejero |
| Cese: 16/07/2012 | DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL |
Consejero |
| Cese: 16/07/2012 | DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL |
Presidente |
| Cese: 16/07/2012 | MASCARAQUE PEREA LUCIO |
Secretario |
| Cese: 16/07/2012 | CORNEJO PABLOS JOSE FERNANDO |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 16/07/2012 | MASCARAQUE PEREA LUCIO |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 16/07/2012 | DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 16/07/2012 | MASCARAQUE PEREA LUCIO |
Administrador único |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by LABOR DE FIGUERUELAS SL
27/09/2017 Details of the advert (384801) Registry data: T 22643 , F 145, S 8, H M 404962, I/A 6 (14.09.17).
- Fe de erratas
SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 6ª LA PUBLICACION DE LAS INSCRIPCIONES QUE SE ANULAN POR SENTENCIA JUDICIAL, QUE SON LA 4ª Y 5ª.
22/09/2017 Details of the advert (380448) Registry data: T 22643 , F 145, S 8, H M 404962, I/A 7 (14.09.17).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL. Presidente: DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL. Cons.Del.Man: DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL.
21/09/2017 Details of the advert (378802) Registry data: T 22643 , F 145, S 8, H M 404962, I/A 6 (14.09.17).
- Fe de erratas
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERANTIL Nº 5 DE MADRID, DE 28 DE MAYO DE 2014, Y AUTO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
11/09/2012 Details of the advert (372511) Registry data: T 22643 , F 144, S 8, H M 404962, I/A 5 (31.08.12).
- Ampliación de Capital
Capital: 1.236.143,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.508.615,00 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.
16/07/2012 Details of the advert (298813) Registry data: T 22643 , F 142, S 8, H M 404962, I/A 4 ( 4.07.12).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: CORNEJO PABLOS JOSE FERNANDO;MASCARAQUE PEREA LUCIO;DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL. Presidente: DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL. Secretario: MASCARAQUE PEREA LUCIO. Cons.Del.Man: CORNEJO PABLOS JOSE FERNANDO;MASCARAQUE PEREA LUCIO;DIAZ CASTRO LUIS MIGUEL.
- Nombramientos
Adm. Unico: MASCARAQUE PEREA LUCIO.
- Ampliación de Capital
Capital: 8.269.462,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.272.472,00 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
17/10/2011 Details of the advert (809486)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2011) Año: 2010
11/10/2010 Details of the advert (804183)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2010) Año: 2009
15/10/2009 Details of the advert (664758)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2009) Año: 2008
Mercantile Registry documents related: 8
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2017-185-28 | 27/09/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-182-28 | 22/09/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-181-28 | 21/09/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-175-28 | 11/09/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-134-28 | 16/07/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2011-197-28 | 17/10/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-196-28 | 11/10/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2009-197-28 | 15/10/2009 | Madrid | Descargar |