KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL

Activa

RONDA DE PONIENTE 14 2º C-D (TRES CANTOS).
 Tres Cantos, Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 24/01/2025

VIR AUDIT SLP

Auditor
Cese: 28/02/2023

DA SINGULAR LAWYERS SLP

Secretario no consejero
Cese: 28/02/2023

PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO

Representante
Nombramiento: 28/02/2023

PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO JORGE

Secretario no consejero
Nombramiento: 28/02/2023

SILVA LLADO MAURICIA MARIA

Vicesecretario no consejero
Cese: 14/02/2018

RICO VILAR ELENA

Representante
Nombramiento: 14/02/2018

ALVAREZ FORN XAVIER

Representante
Nombramiento: 16/06/2017

PEÑA PEREZ AQUILINO MIGUEL

Consejero
Nombramiento: 16/06/2017

ELIZAGA VIANA CESAR

Consejero
Nombramiento: 16/06/2017

PARDO VIDAL CARLOS

Consejero delegado
Cese: 28/12/2016

PEREZ MERINO SERGIO

Representante
Nombramiento: 28/12/2016

RICO VILAR ELENA

Representante
Cese: 08/05/2013

VIALEGIS DUTILH SLP

Secretario no consejero
Cese: 08/05/2013

PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO

Representante
Nombramiento: 08/05/2013

DUTILH ABOGADOS SLP

Secretario no consejero
Nombramiento: 08/05/2013

PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO

Representante
Nombramiento: 30/01/2012

CAIXA CAPITAL PYME INNOVACION SCR DE REGIMEN SIMPL

Consejero
Nombramiento: 30/01/2012

PEREZ MERINO SERGIO

Representante
Cese: 27/12/2011

PARDO VIDAL CARLOS

Administrador único
Nombramiento: 27/12/2011

VIALEGIS DUTILH SLP

Secretario no consejero
Nombramiento: 27/12/2011

BULLNET GESTION SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE C

Consejero
Nombramiento: 27/12/2011

PARDO YAÑEZ JUAN

Consejero
Nombramiento: 27/12/2011

PARDO VIDAL CARLOS

Consejero
Nombramiento: 27/12/2011

PEREZ DE ARANDA RUBEN-ISRAEL

Consejero
Nombramiento: 27/12/2011

PARDO VIDAL CARLOS

Presidente
Nombramiento: 27/12/2011

PARDO VIDAL CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 27/12/2011

PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO

Representante
Nombramiento: 27/12/2011

ULECIA RODRIGUEZ JAVIER

Representante
Cese: 20/05/2011

PARDO VIDAL CARLOS

Administrador único
Nombramiento: 20/05/2011

PARDO VIDAL CARLOS

Administrador único

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL

24/01/2025 Details of the advert (38100) Registry data: S 8 , H M 495193, I/A 47 (17.01.25).

  • Nombramientos

    Auditor: VIR AUDIT SLP.

09/10/2024 Details of the advert (430623) Registry data: S 8 , H M 495193, I/A 46 ( 2.10.24).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 2.088,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.552.577,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 54.727,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.607.304,00 Euros.

28/02/2023 Details of the advert (104214) Registry data: T 37575 , F 28, S 8, H M 495193, I/A 43 (21.02.23).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: DA SINGULAR LAWYERS SLP. Representan: PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: PORTABALES GONZALEZ-CHOREN IVO JORGE. VsecrNoConsj: SILVA LLADO MAURICIA MARIA.

07/06/2021 Details of the advert (274334) Registry data: T 37575 , F 27, S 8, H M 495193, I/A 42 (31.05.21).

    27/05/2021 Details of the advert (255938) Registry data: T 37575 , F 25, S 8, H M 495193, I/A 41 (20.05.21).

    • Reducción de Capital

      Importe reducción: 577.942,16 Euros. Resultante Suscrito: 1.934.849,84 Euros.

    • Escisión Parcial

      Sociedades beneficiarias de la escisión: KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR RUGGED OPTICAL COMMUNICA.

    28/01/2021 Details of the advert (41758) Registry data: T 37575 , F 24, S 8, H M 495193, I/A 40 (21.01.21).

    • Ampliación de Capital

      Capital: 152.650,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.512.792,00 Euros.

    18/06/2020 Details of the advert (186208) Registry data: T 37575 , F 24, S 8, H M 495193, I/A 39 (11.06.20).

      28/01/2020 Details of the advert (38626) Registry data: T 37575 , F 23, S 8, H M 495193, I/A 38 (21.01.20).

      • Ampliación de Capital

        Capital: 33.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.360.142,00 Euros.

      10/01/2020 Details of the advert (8526) Registry data: T 37575 , F 22, S 8, H M 495193, I/A 37 (30.12.19).

      • Ampliación de Capital

        Capital: 6.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.326.392,00 Euros.

      08/11/2019 Details of the advert (462692) Registry data: T 37575 , F 21, S 8, H M 495193, I/A 36 (31.10.19).

      • Ampliación de Capital

        Capital: 84.375,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.319.892,00 Euros.

      Mercantile Registry documents related: 45

      #CVE
      Date
      State
      BORME-A-2025-16-28 24/01/2025 Madrid Descargar
      BORME-A-2024-195-28 09/10/2024 Madrid Descargar
      BORME-A-2023-41-28 28/02/2023 Madrid Descargar
      BORME-A-2021-106-28 07/06/2021 Madrid Descargar
      BORME-A-2021-99-28 27/05/2021 Madrid Descargar
      BORME-A-2021-18-28 28/01/2021 Madrid Descargar
      BORME-A-2020-116-28 18/06/2020 Madrid Descargar
      BORME-A-2020-18-28 28/01/2020 Madrid Descargar
      BORME-A-2020-6-28 10/01/2020 Madrid Descargar
      BORME-A-2019-215-28 08/11/2019 Madrid Descargar