KELLY SERVICES SELECCION Y FORMACION SL

Extinta

PLAZA PABLO RUIZ PICASSO 1 - TORRE PICASSO, PLANTA (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 17/01/2013

CAMDEN CARL T

Presidente
Cese: 17/01/2013

AGNEUS LEIF STURE ROLAND

Consejero
Cese: 17/01/2013

DEBS MICHAEL E

Consejero
Cese: 17/01/2013

CAMDEN CARL T

Consejero
Cese: 17/01/2013

GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO

Secretario
Cese: 17/01/2013

MEDINA SANCHEZ BELEN

Vicesecretario
Cese: 17/01/2013

KELLY SERVICES INC

Socio único
Nombramiento: 17/01/2013

THIROT OLIVIER GABRIEL BERNARD MARIA

Liquidador
Nombramiento: 10/08/2012

GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 10/08/2012

MEDINA SANCHEZ BELEN

Apoderado
Nombramiento: 10/08/2012

FALCONI MICAELA

Apoderado
Cese: 05/01/2012

THIROT OLIVIER

Apoderado
Cese: 05/01/2012

PECQUEUR STEPHANE CHRISTIAN MARC

Apoderado
Cese: 05/01/2012

THIROT OLIVIER

Apoderado
Nombramiento: 05/01/2012

THIROT OLIVIER

Apoderado
Nombramiento: 04/10/2010

CAMDEN CARL T

Consejero
Cese: 22/07/2010

ARCILA FERRANDO JOSE ANTONIO

Secretario
Cese: 22/07/2010

TOMMASINI BERNARD

Apoderado
Cese: 22/07/2010

GALLARDO MOROTE ANTONIO

Apoderado
Cese: 22/07/2010

OLALLA BLANCO VICTORIA

Apoderado
Cese: 22/07/2010

AGNEUS LEIF STURE ROLAND

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 22/07/2010

SERRANO GUERRA CRISTINA

Apoderado
Cese: 22/07/2010

GALLARDO MOROTE ANTONIO

Apoderado
Cese: 22/07/2010

TERRAL LIONEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 22/07/2010

MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA

Apoderado
Cese: 22/07/2010

GIL ACACIO MARIA DEL PILAR

Apoderado
Cese: 22/07/2010

DIAZ CRESPO ROSALIA

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2010

GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO

Secretario
Nombramiento: 22/07/2010

MEDINA SANCHEZ BELEN

Vicesecretario
Nombramiento: 22/07/2010

PECQUEUR STEPHANE CHRISTIAN MARC

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2010

THIROT OLIVIER

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2010

AGNEUS LEIF STURE ROLAND

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2010

OHLE JENS PETER

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2010

EMERY BRADLEY T

Apoderado
Nombramiento: 22/07/2010

WESSBECHER HUBERTUS

Apoderado
Cese: 29/05/2009

BLANCO VILLALBA RAQUEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 29/05/2009

GIORGETTI STEFANO

Apoderado
Nombramiento: 29/05/2009

TERRAL LIONEL

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 29/05/2009

MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA

Apoderado
Nombramiento: 29/05/2009

GIL ACACIO MARIA DEL PILAR

Apoderado
Nombramiento: 29/05/2009

DIAZ CRESPO ROSALIA

Apoderado
Cese: 06/02/2009

GALLARDO MOROTE ANTONIO

Apoderado solidario
Cese: 06/02/2009

PEREZ CUEVAS IGNACIO

Apoderado solidario
Cese: 06/02/2009

PEREZ RESURRECCION CARLOS

Apoderado
Cese: 06/02/2009

WALLACE RICHARD FRANCIS

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 06/02/2009

KLEINER ROLF E

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 06/02/2009

SERRANO GUERRA CRISTINA

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2009

LITTLE PATRICIA ANN

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2009

THIROT OLIVIER

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2009

GALLARDO MOROTE ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2009

SERRANO GUERRA CRISTINA

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2009

GIORGETTI STEFANO

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2009

GIORGETTI STEFANO

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by KELLY SERVICES SELECCION Y FORMACION SL

17/01/2013 Details of the advert (23385) Registry data: T 25689 , F 85, S 8, H M 182007, I/A 44 ( 9.01.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: CAMDEN CARL T. Consejero: AGNEUS LEIF STURE ROLAND;DEBS MICHAEL E;CAMDEN CARL T. Secretario: GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO. Vicesecret.: MEDINA SANCHEZ BELEN. Socio único: KELLY SERVICES INC.

  • Nombramientos

    Liquidador: THIROT OLIVIER GABRIEL BERNARD MARIA.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

10/08/2012 Details of the advert (337913) Registry data: T 25689 , F 85, S 8, H M 182007, I/A 43 (30.07.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO;MEDINA SANCHEZ BELEN;FALCONI MICAELA.

05/01/2012 Details of the advert (7169) Registry data: T 25689 , F 82, S 8, H M 182007, I/A 42 (27.12.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: THIROT OLIVIER;PECQUEUR STEPHANE CHRISTIAN MARC;THIROT OLIVIER.

  • Nombramientos

    Apoderado: THIROT OLIVIER.

14/06/2011 Details of the advert (254408) Registry data: T 25689 , F 82, S 8, H M 182007, I/A 41 ( 2.06.11).

  • Cambio de domicilio social

    PLAZA PABLO RUIZ PICASSO 1 - TORRE PICASSO, PLANTA (MADRID).

19/11/2010 Details of the advert (1063065)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2010) Año: 2009

04/10/2010 Details of the advert (370802) Registry data: T 25689 , F 82, S 8, H M 182007, I/A 40 (22.09.10).

  • Reelecciones

    Consejero: CAMDEN CARL T.

16/09/2010 Details of the advert (353269) Registry data: T 25689 , F 81, S 8, H M 182007, I/A 39 (30.08.10).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 6.782.413,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.025,00 Euros.

28/07/2010 Details of the advert (260122)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2008

22/07/2010 Details of the advert (289110) Registry data: T 25689 , F 78, S 8, H M 182007, I/A 38 (13.07.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: ARCILA FERRANDO JOSE ANTONIO.

  • Revocaciones

    Apoderado: TOMMASINI BERNARD;GALLARDO MOROTE ANTONIO;OLALLA BLANCO VICTORIA. Apo.Man.Soli: AGNEUS LEIF STURE ROLAND. Apoderado: SERRANO GUERRA CRISTINA;GALLARDO MOROTE ANTONIO. Apo.Man.Soli: TERRAL LIONEL. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;DIAZ CRESPO ROSALIA.

  • Nombramientos

    Secretario: GONZALEZ DE ZULUETA FERNANDO. Vicesecret.: MEDINA SANCHEZ BELEN. Apoderado: PECQUEUR STEPHANE CHRISTIAN MARC;THIROT OLIVIER;AGNEUS LEIF STURE ROLAND;OHLE JENS PETER;EMERY BRADLEY T.;WESSBECHER HUBERTUS.

  • Otros Conceptos

    MODIFICACION DE LA FORMA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 37&.

  • Cambio de domicilio social

    C/ FRANCISCO GIRALTE, Nº 2 (MADRID).

29/05/2009 Details of the advert (245675) Registry data: T 25689 , F 78, S 8, H M 182007, I/A 37 (14.05.09).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: BLANCO VILLALBA RAQUEL. Apoderado: GIORGETTI STEFANO.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: TERRAL LIONEL. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;DIAZ CRESPO ROSALIA.

Mercantile Registry documents related: 12

#CVE
Date
State
BORME-A-2013-11-28 17/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-153-28 10/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-4-28 05/01/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-113-28 14/06/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-222-28 19/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-191-28 04/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-179-28 16/09/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-143-28 28/07/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-139-28 22/07/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2009-100-28 29/05/2009 Madrid Descargar