IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

Extinta

C/ GENERAL PARDIÑAS 114 - 1º A (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 06/07/2018

SORDO MIRALLES ARTURO TOMAS

Representante perma.
Cese: 06/07/2018

MENDEZ ZORI JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 06/07/2018

MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA

Apoderado
Cese: 06/07/2018

PEREZ MANSILLA DELGADO PATRICIA

Apoderado
Cese: 06/07/2018

DIAZ CRESPO ROSALIA

Apoderado solidario
Cese: 06/07/2018

MEDINA DE TORO CARLOS

Apoderado solidario
Cese: 06/07/2018

ROMBOLI MARIA TERESA

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/05/2018

MEDINA DE TORO CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/05/2018

ROMBOLI MARIA TERESA

Apoderado solidario
Cese: 05/07/2017

DENTON DAVID JOHN

Representante perma.
Cese: 05/07/2017

SORDO MIRALLES ARTURO TOMAS

Representante perma.
Nombramiento: 05/07/2017

SORDO MIRALLES ARTURO TOMAS

Representante perma.

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

06/07/2018 Details of the advert (282870) Registry data: T 27201 , F 53, S 8, H M 490085, I/A 12 (28.06.18).

  • Ceses/Dimisiones

    R.L.C.Perma.: SORDO MIRALLES ARTURO TOMAS.

  • Revocaciones

    Apoderado: MENDEZ ZORI JOSE MARIA;MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;PEREZ MANSILLA DELGADO PATRICIA. Apo.Sol.: DIAZ CRESPO ROSALIA;MEDINA DE TORO CARLOS;ROMBOLI MARIA TERESA.

  • Extinción

04/05/2018 Details of the advert (191408) Registry data: T 27201 , F 51, S 8, H M 490085, I/A 11 (24.04.18).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: MEDINA DE TORO CARLOS;ROMBOLI MARIA TERESA.

11/07/2017 Details of the advert (284964) Registry data: T 27201 , F 29, S 8, H M 490085, I/A 10 ( 3.07.17).

  • Otros Conceptos

    QUE EN LA ACTUALIDAD EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ, ESTA COMPUESTO POR D. MATTHEW ALEXANDER; D. TIMOTHY BRENT NOVAK.-

05/07/2017 Details of the advert (277383) Registry data: T 27201 , F 28, S 8, H M 490085, I/A 9 (27.06.17).

  • Ceses/Dimisiones

    R.L.C.Per.M.: DENTON DAVID JOHN;SORDO MIRALLES ARTURO TOMAS.

  • Nombramientos

    R.L.C.Perma.: SORDO MIRALLES ARTURO TOMAS.

21/03/2017 Details of the advert (126339) Registry data: T 27201 , F 27, S 8, H M 490085, I/A 8 (10.03.17).

  • Cambio de domicilio social

    C/ GENERAL PARDIÑAS 114 - 1º A (MADRID).

24/02/2017 Details of the advert (92402) Registry data: T 27201 , F 27, S 8, H M 490085, I/A 7 (17.02.17).

  • Otros Conceptos

    QUE EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ, ESTA INTEGRADO POR: DON RONALD WILLIAM BUCKLY (estadounidense); DON MARK DUNCAN CHAPLAIN (britanico), DON DAVID JOHN DENTON (britanico), DON BRENT TIMOTHY NOVAK (estadounidense).

15/09/2014 Details of the advert (366579) Registry data: T 27201 , F 27, S 8, H M 490085, I/A 6 ( 4.09.14).

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ EN RELACION CON LA SUCURSAL EN ESPAÑA; DON RONALD WILLIAM BUCKLY, PASAPORTE 442681047; DON MARK DUNCAN CHAPLAIN, PASAPORTE 800286248; DON DAVID JOHN DENTON, PASAPORTE 202439564.

18/07/2012 Details of the advert (302793) Registry data: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 5 ( 6.07.12).

  • Otros Conceptos

    Cambiado el domicilio de IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITEDsociedad matriz de la sucursal a MAIN BUILDING HARTHAM PARK, CORSHAM, WILTSHIRE SN13 ORP.

08/06/2012 Details of the advert (242959) Registry data: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 3 (29.05.12).

  • Cambio de domicilio social

    C/ LA BOTANICA 4 - P2 (MADRID).

08/06/2012 Details of the advert (242960) Registry data: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 4 (29.05.12).

  • Otros Conceptos

    Modificada con fecha 1 de febrero de 2010 la denominación de la sociedad matriz de la sucursal a IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED.

Mercantile Registry documents related: 10

#CVE
Date
State
BORME-A-2018-129-28 06/07/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-85-28 04/05/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-130-28 11/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-126-28 05/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-55-28 21/03/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-39-28 24/02/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2014-175-28 15/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2012-136-28 18/07/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-108-28 08/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-108-28 08/06/2012 Madrid Descargar