IRUS CENTER GETAFE SL

Cambio de denominación social

C/ FRANCISCA DELGADO 11 5ª (ALCOBENDAS).
 Alcobendas, Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 15/02/2017

FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA

Consejero
Cese: 15/02/2017

SEGOFIELD SL

Consejero
Cese: 15/02/2017

JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT

Consejero
Cese: 15/02/2017

FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA

Presidente
Cese: 15/02/2017

SEGOFIELD SL

Secretario
Cese: 15/02/2017

LOSANTOS EGEA DANIEL

Representante
Cese: 15/02/2017

GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO

Representante
Cese: 15/02/2017

GUIRAO PEREZ MARTA

Representante
Nombramiento: 15/02/2017

WHITE CARL SOLOMON

Administrador solidario
Nombramiento: 15/02/2017

ACHESON JAMES PATRICK

Administrador solidario
Nombramiento: 15/02/2017

CEBALLOS FERNANDEZ EDUARDO

Administrador solidario
Nombramiento: 15/02/2017

CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Administrador solidario
Nombramiento: 13/02/2017

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Nombramiento: 08/02/2017

ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 08/02/2017

TORRALBA DE LA FUENTE JAVIER

Apoderado mancomunado
Cese: 31/01/2017

NEINVER SA

Apoderado
Nombramiento: 31/01/2017

LOSANTOS EGEA DANIEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

GUIRAO PEREZ MARTA MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

GELADO CRESPO VANESA

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

DIEZ SOLER LORENA

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

DE PABLO DIEZ MARIA ELENA

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

FERNANDEZ-DAZA DE ALVEAR JOSE MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/01/2017

CARRASCO DIAZ GUILLERMO

Apoderado solidario
Nombramiento: 11/12/2015

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Cese: 07/12/2015

TOPOLSKA BARBARA MARTA

Representante
Nombramiento: 07/12/2015

GUIRAO PEREZ MARTA

Representante
Nombramiento: 27/11/2014

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Nombramiento: 22/08/2013

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Cese: 19/08/2013

LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA

Administrador mancomunado
Cese: 19/08/2013

MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA

Administrador mancomunado
Nombramiento: 19/08/2013

FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA

Consejero
Nombramiento: 19/08/2013

SEGOFIELD SL

Consejero
Nombramiento: 19/08/2013

JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT

Consejero
Nombramiento: 19/08/2013

FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA

Presidente
Nombramiento: 19/08/2013

SEGOFIELD SL

Secretario
Nombramiento: 19/08/2013

LOSANTOS EGEA DANIEL

Representante
Nombramiento: 19/08/2013

GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO

Representante
Nombramiento: 19/08/2013

TOPOLSKA BARBARA MARTA

Representante

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by IRUS CENTER GETAFE SL

15/02/2017 Details of the advert (75112) Registry data: T 34796 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 23 ( 7.02.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA;SEGOFIELD SL;JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT. Presidente: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA. Secretario: SEGOFIELD SL. Representan: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;GUIRAO PEREZ MARTA.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: WHITE CARL SOLOMON;ACHESON JAMES PATRICK;CEBALLOS FERNANDEZ EDUARDO;CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER.

  • Modificaciones Estatutarias

    Modificados y refundidos los estatutos sociales.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.

  • Cambio de denominación social

    NEPTUNE GETAFE PROPCO SL.

  • Cambio de domicilio social

    C/ FRANCISCA DELGADO 11 5ª (ALCOBENDAS).

  • Cambio de objeto social

    ADQUISICION, PROMOCION, TENENCIA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.

13/02/2017 Details of the advert (69866) Registry data: T 30961 , F 211, S 8, H M 408977, I/A 22 ( 3.02.17).

  • Reelecciones

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

08/02/2017 Details of the advert (63297) Registry data: T 30961 , F 211, S 8, H M 408977, I/A 21 (31.01.17).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS;TORRALBA DE LA FUENTE JAVIER.

31/01/2017 Details of the advert (49127) Registry data: T 30961 , F 211, S 8, H M 408977, I/A 20 (23.01.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: NEINVER SA.

31/01/2017 Details of the advert (49126) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 19 (20.01.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GUIRAO PEREZ MARTA MARIA;GELADO CRESPO VANESA;DIEZ SOLER LORENA;DE PABLO DIEZ MARIA ELENA;FERNANDEZ-DAZA DE ALVEAR JOSE MARIA;GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN;CARRASCO DIAZ GUILLERMO.

11/12/2015 Details of the advert (502472) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 18 ( 2.12.15).

  • Reelecciones

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

07/12/2015 Details of the advert (496096) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 17 (27.11.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: TOPOLSKA BARBARA MARTA.

  • Nombramientos

    Representan: GUIRAO PEREZ MARTA.

27/11/2014 Details of the advert (484466) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 16 (20.11.14).

  • Reelecciones

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

22/08/2013 Details of the advert (372992) Registry data: T 30961 , F 209, S 8, H M 408977, I/A 15 (13.08.13).

  • Reelecciones

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

19/08/2013 Details of the advert (366852) Registry data: T 30961 , F 209, S 8, H M 408977, I/A 14 ( 8.08.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA.

  • Nombramientos

    Consejero: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA;SEGOFIELD SL;JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT. Presidente: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA. Secretario: SEGOFIELD SL. Representan: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;TOPOLSKA BARBARA MARTA.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración.

Mercantile Registry documents related: 19

#CVE
Date
State
BORME-A-2017-32-28 15/02/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-30-28 13/02/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-27-28 08/02/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-21-28 31/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-21-28 31/01/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2015-236-28 11/12/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-233-28 07/12/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-227-28 27/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-159-28 22/08/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-156-28 19/08/2013 Madrid Descargar