IRUS CENTER GETAFE SL
Cambio de denominación social
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 15/02/2017 | FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA |
Consejero |
| Cese: 15/02/2017 | SEGOFIELD SL |
Consejero |
| Cese: 15/02/2017 | JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT |
Consejero |
| Cese: 15/02/2017 | FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA |
Presidente |
| Cese: 15/02/2017 | SEGOFIELD SL |
Secretario |
| Cese: 15/02/2017 | LOSANTOS EGEA DANIEL |
Representante |
| Cese: 15/02/2017 | GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO |
Representante |
| Cese: 15/02/2017 | GUIRAO PEREZ MARTA |
Representante |
| Nombramiento: 15/02/2017 | WHITE CARL SOLOMON |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 15/02/2017 | ACHESON JAMES PATRICK |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 15/02/2017 | CEBALLOS FERNANDEZ EDUARDO |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 15/02/2017 | CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 13/02/2017 | ERNST & YOUNG SL |
Auditor |
| Nombramiento: 08/02/2017 | ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 08/02/2017 | TORRALBA DE LA FUENTE JAVIER |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 31/01/2017 | NEINVER SA |
Apoderado |
| Nombramiento: 31/01/2017 | LOSANTOS EGEA DANIEL |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | GUIRAO PEREZ MARTA MARIA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | GELADO CRESPO VANESA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | DIEZ SOLER LORENA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | DE PABLO DIEZ MARIA ELENA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | FERNANDEZ-DAZA DE ALVEAR JOSE MARIA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 31/01/2017 | CARRASCO DIAZ GUILLERMO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 11/12/2015 | ERNST & YOUNG SL |
Auditor |
| Cese: 07/12/2015 | TOPOLSKA BARBARA MARTA |
Representante |
| Nombramiento: 07/12/2015 | GUIRAO PEREZ MARTA |
Representante |
| Nombramiento: 27/11/2014 | ERNST & YOUNG SL |
Auditor |
| Nombramiento: 22/08/2013 | ERNST & YOUNG SL |
Auditor |
| Cese: 19/08/2013 | LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA |
Administrador mancomunado |
| Cese: 19/08/2013 | MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA |
Administrador mancomunado |
| Nombramiento: 19/08/2013 | FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA |
Consejero |
| Nombramiento: 19/08/2013 | SEGOFIELD SL |
Consejero |
| Nombramiento: 19/08/2013 | JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT |
Consejero |
| Nombramiento: 19/08/2013 | FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA |
Presidente |
| Nombramiento: 19/08/2013 | SEGOFIELD SL |
Secretario |
| Nombramiento: 19/08/2013 | LOSANTOS EGEA DANIEL |
Representante |
| Nombramiento: 19/08/2013 | GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO |
Representante |
| Nombramiento: 19/08/2013 | TOPOLSKA BARBARA MARTA |
Representante |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by IRUS CENTER GETAFE SL
15/02/2017 Details of the advert (75112) Registry data: T 34796 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 23 ( 7.02.17).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA;SEGOFIELD SL;JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT. Presidente: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA. Secretario: SEGOFIELD SL. Representan: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;GUIRAO PEREZ MARTA.
- Nombramientos
Adm. Solid.: WHITE CARL SOLOMON;ACHESON JAMES PATRICK;CEBALLOS FERNANDEZ EDUARDO;CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER.
- Modificaciones Estatutarias
Modificados y refundidos los estatutos sociales.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.
- Cambio de denominación social
NEPTUNE GETAFE PROPCO SL.
- Cambio de domicilio social
C/ FRANCISCA DELGADO 11 5ª (ALCOBENDAS).
- Cambio de objeto social
ADQUISICION, PROMOCION, TENENCIA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.
13/02/2017 Details of the advert (69866) Registry data: T 30961 , F 211, S 8, H M 408977, I/A 22 ( 3.02.17).
- Reelecciones
Auditor: ERNST & YOUNG SL.
08/02/2017 Details of the advert (63297) Registry data: T 30961 , F 211, S 8, H M 408977, I/A 21 (31.01.17).
- Nombramientos
Apo.Manc.: ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS;TORRALBA DE LA FUENTE JAVIER.
31/01/2017 Details of the advert (49127) Registry data: T 30961 , F 211, S 8, H M 408977, I/A 20 (23.01.17).
- Revocaciones
Apoderado: NEINVER SA.
31/01/2017 Details of the advert (49126) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 19 (20.01.17).
- Nombramientos
Apo.Sol.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GUIRAO PEREZ MARTA MARIA;GELADO CRESPO VANESA;DIEZ SOLER LORENA;DE PABLO DIEZ MARIA ELENA;FERNANDEZ-DAZA DE ALVEAR JOSE MARIA;GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN;CARRASCO DIAZ GUILLERMO.
11/12/2015 Details of the advert (502472) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 18 ( 2.12.15).
- Reelecciones
Auditor: ERNST & YOUNG SL.
07/12/2015 Details of the advert (496096) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 17 (27.11.15).
- Ceses/Dimisiones
Representan: TOPOLSKA BARBARA MARTA.
- Nombramientos
Representan: GUIRAO PEREZ MARTA.
27/11/2014 Details of the advert (484466) Registry data: T 30961 , F 210, S 8, H M 408977, I/A 16 (20.11.14).
- Reelecciones
Auditor: ERNST & YOUNG SL.
22/08/2013 Details of the advert (372992) Registry data: T 30961 , F 209, S 8, H M 408977, I/A 15 (13.08.13).
- Reelecciones
Auditor: ERNST & YOUNG SL.
19/08/2013 Details of the advert (366852) Registry data: T 30961 , F 209, S 8, H M 408977, I/A 14 ( 8.08.13).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Mancom.: LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA.
- Nombramientos
Consejero: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA;SEGOFIELD SL;JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SOCIEDAD EN COMANDIT. Presidente: FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA. Secretario: SEGOFIELD SL. Representan: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;TOPOLSKA BARBARA MARTA.
- Modificaciones Estatutarias
Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración.
Mercantile Registry documents related: 19
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2017-32-28 | 15/02/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-30-28 | 13/02/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-27-28 | 08/02/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-21-28 | 31/01/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-21-28 | 31/01/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-236-28 | 11/12/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-233-28 | 07/12/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-227-28 | 27/11/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-159-28 | 22/08/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-156-28 | 19/08/2013 | Madrid | Descargar |