IBERLOIX SL

Extinta

C/ RAFAEL CALVO 42, ESCALERA IZQUIERDA, 4º (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 20/12/2016

ROYAN ASENSIO MARIA ISABEL

Apoderado
Nombramiento: 20/12/2016

JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO

Apoderado
Cese: 20/12/2016

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador solidario
Cese: 19/08/2016

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador único
Nombramiento: 19/08/2016

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador solidario
Nombramiento: 19/08/2016

JIMENEZ ROYAN MARIA

Administrador solidario
Cese: 04/04/2013

GARCIA PEREZ EUGENIO

Administrador único
Nombramiento: 04/04/2013

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador único
Cese: 26/01/2011

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador mancomunado
Cese: 26/01/2011

GARCIA PEREZ EUGENIO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 26/01/2011

GARCIA PEREZ EUGENIO

Administrador único
Nombramiento: 13/02/2009

PEÑA ANGULO MIGUEL ANGEL

Auditor
Nombramiento: 13/02/2009

MORELL BALDO TOMAS

Auditor suplente
Cese: 27/01/2009

COLLADO RODRIGUEZ RAUL

Apoderado
Cese: 16/01/2009

SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO

Administrador solidario
Cese: 16/01/2009

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador solidario
Nombramiento: 16/01/2009

SANCHEZ MIRANDA ESTHER

Administrador mancomunado
Nombramiento: 16/01/2009

GARCIA PEREZ EUGENIO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 16/01/2009

SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by IBERLOIX SL

17/11/2017 Details of the advert (452518) Registry data: T 26010 , F 121, S 8, H M 65253, I/A 28 (10.11.17).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

20/12/2016 Details of the advert (514051) Registry data: T 26010 , F 119, S 8, H M 65253, I/A 27 (12.12.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: ROYAN ASENSIO MARIA ISABEL.

20/12/2016 Details of the advert (514050) Registry data: T 26010 , F 117, S 8, H M 65253, I/A 26 (12.12.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO.

20/12/2016 Details of the advert (514049) Registry data: T 26010 , F 116, S 8, H M 65253, I/A 25 (12.12.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: SANCHEZ MIRANDA ESTHER.

19/08/2016 Details of the advert (342530) Registry data: T 26010 , F 114, S 8, H M 65253, I/A 24 (29.07.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: SANCHEZ MIRANDA ESTHER.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: SANCHEZ MIRANDA ESTHER;JIMENEZ ROYAN MARIA.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 201.669,05 Euros. Resultante Suscrito: 818.577,98 Euros.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: IBERMURTAL SL.

04/04/2013 Details of the advert (157687) Registry data: T 26010 , F 113, S 8, H M 65253, I/A 23 (26.03.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GARCIA PEREZ EUGENIO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SANCHEZ MIRANDA ESTHER.

25/03/2011 Details of the advert (116077)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2010) Año: 2009

26/01/2011 Details of the advert (31650) Registry data: T 26010 , F 113, S 8, H M 65253, I/A 22 (13.01.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: SANCHEZ MIRANDA ESTHER;GARCIA PEREZ EUGENIO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GARCIA PEREZ EUGENIO.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único.

15/12/2009 Details of the advert (521418) Registry data: T 26010 , F 113, S 8, H M 65253, I/A 21 ( 2.12.09).

  • Otros Conceptos

    Inscrita la renuncia de DON GREGORIO JIMENEZ BLAZQUEZ al poder que le fue conferido el 15 de noviembre de 1.990.

22/10/2009 Details of the advert (708640)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 15

#CVE
Date
State
BORME-A-2017-219-28 17/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-240-28 20/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-240-28 20/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-240-28 20/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-158-28 19/08/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2013-63-28 04/04/2013 Madrid Descargar
BORME-B-2011-59-28 25/03/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-17-28 26/01/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2009-238-28 15/12/2009 Madrid Descargar
BORME-B-2009-202-28 22/10/2009 Madrid Descargar