IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SA
Cambio de denominación social
If you want to update or modify register for free
Last movements
Date
|
Name
|
|
---|---|---|
Nombramiento: 18/07/2014 | ERNST & YOUNG SL |
Auditor de cuentas |
Nombramiento: 27/02/2014 | VILLARINO TAMAME JOSE LUIS |
Apoderado mancomunado |
Nombramiento: 27/02/2014 | VILLARINO TAMAME JOSE LUIS |
Apoderado solidario mancomunado |
Nombramiento: 27/02/2014 | GRANDE PAREDES MARIA DE LA O |
Apoderado solidario mancomunado |
Nombramiento: 27/02/2014 | RUIZ CORACHAN CARLOS |
Apoderado solidario mancomunado |
Nombramiento: 11/10/2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
Nombramiento: 24/02/2012 | CALLEJA FERNANDEZ ALFONSO |
Apoderado |
Nombramiento: 24/02/2012 | CASTELLANO SANCHEZ JUAN |
Administrador conjunto |
Cese: 13/01/2012 | DE PEÑARANDA GONZALEZ ROBATTO MARTA |
Apoderado |
Cese: 13/01/2012 | DIAZ GARCIA VIRGINIA |
Apoderado |
Cese: 13/01/2012 | MARTINEZ SEQUERA JOSE |
Apoderado |
Cese: 22/07/2011 | DORIA DE ELEJOSTE ADRIANA |
Administrador conjunto |
Nombramiento: 22/07/2011 | DE MUNSURI PINSAN FRANCISCO |
Administrador conjunto |
Nombramiento: 03/01/2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
Cese: 15/04/2010 | SANCHEZ CASTELLANO EMILIO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | CARRIEDO PENAS GABRIEL |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | VAZQUEZ MARTINEZ DE PINILLOS EMILIO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | CARNERO FERNANDEZ JOSE VICENTE |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | MARTINEZ SEQUERA JOSE |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | CASTELLANO SANCHEZ JUAN |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | DE MUNSURI PINSAN FRANCISCO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | LIZASOAIN URCOLA RAMON |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | CASANOVAS ESCUSSOL JAUME |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | BUENO BERMEJO CARLOS |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | GUZMAN ALONSO ALLENDE GUILLERMO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | DIAZ GARCIA VIRGINIA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | PEREZ ASENSIO MARIA JOSE |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | BARBERO RODRIGUEZ ISABEL |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | ALEMAN HERRANZ BEATRIZ |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | RODRIGUEZ DE BLAS CRISTINA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | MARTIN ESTEBAN EVA MARIA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | BALLESTEROS GODIA JOSEP MARIA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | MARTIN VALLADOLID CRISTINA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | GILABERTE FORTEA ALFREDO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | MENENDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | CAMARERO CANDELA MIGUEL ANGEL |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | DE PEÑARANDA GONZALEZ ROBATTO MARTA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | GUTIERREZ CRESPO MARIA TERESA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | MARTIN GONZALEZ BEATRIZ |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | BARRIO HERRAEZ VIRGINIA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | SANCHEZ GUINDAL FRANCISCO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | ESTEBAN CORTES CARLOS |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | ALONSO GARCIA CAROLINA |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | SAINZ ARMADA JOSE |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | MARTINEZ PEREZ JESUS |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | CASAS TXINTXURRETA PABLO |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR |
Apoderado |
Cese: 15/04/2010 | YBARRA ECHAVARRIA LUIS |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | SANCHEZ CASTELLANO EMILIO |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | CARRIEDO PENAS GABRIEL |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | CARNERO FERNANDEZ JOSE VICENTE |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | MARTINEZ SEQUERA JOSE |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | CASTELLANO SANCHEZ JUAN |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | DE MUNSURI PINSAN FRANCISCO |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | PEREZ ASENSIO MARIA JOSE |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | DIAZ GARCIA VIRGINIA |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | MENENDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | TOLL NAVARRO SUSANA |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | SEVA GONZALEZ EMILIA |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | CAMARERO CANDELA MIGUEL ANGEL |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | DE PEÑARANDA GONZALEZ ROBATTO MARTA |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | GUTIERREZ CRESPO MARIA TERESA |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | PEREZ IGUALADOR ENCARNACION |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | ESTEBAN CORTES CARLOS |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | SANCHEZ GUINDAL FRANCISCO |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | ALONSO GARCIA CAROLINA |
Apoderado |
Nombramiento: 15/04/2010 | BARRIO HERRAEZ VIRGINIA |
Apoderado |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SA
15/09/2014 Details of the advert (366187) Registry data: T 44238 , F 51, S 8, H B 131133, I/A 83 ( 2.09.14).
- Cambio de denominación social
IBERDROLA INMOBILIARIA PATRIMONIO SA.
18/07/2014 Details of the advert (297192) Registry data: T 44238 , F 51, S 8, H B 131133, I/A 82 (10.07.14).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL.
27/02/2014 Details of the advert (91403) Registry data: T 44238 , F 51, S 8, H B 131133, I/A 81 (19.02.14).
- Nombramientos
APOD.MANCOMU: VILLARINO TAMAME JOSE LUIS.
27/02/2014 Details of the advert (91402) Registry data: T 40543 , F 100, S 8, H B 131133, I/A 80 (19.02.14).
- Nombramientos
APOD.SOL/MAN: VILLARINO TAMAME JOSE LUIS;GRANDE PAREDES MARIA DE LA O;RUIZ CORACHAN CARLOS.
04/02/2014 Details of the advert (50333) Registry data: T 40543 , F 100, S 8, H B 131133, I/A 79 (28.01.14).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 65.250.029,10 Euros. Desembolsado: 65.250.029,10 Euros. Resultante Suscrito: 110.494.811,60 Euros. Resultante Desembolsado: 110.494.811,60 Euros.
11/10/2013 Details of the advert (435938) Registry data: T 40543 , F 99, S 8, H B 131133, I/A 78 ( 4.10.13).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
20/08/2013 Details of the advert (368017) Registry data: T 40543 , F 99, S 8, H B 131133, I/A 77 (12.08.13).
- Cambio de domicilio social
PS DE LA ZONA FRANCA,111,MODULO D,TORRE AUDITORI P (BARCELONA).
24/02/2012 Details of the advert (90905) Registry data: T 40543 , F 99, S 8, H B 131133, I/A 75 (15.02.12).
- Nombramientos
APODERADO: CALLEJA FERNANDEZ ALFONSO.
24/02/2012 Details of the advert (90904) Registry data: T 40543 , F 99, S 8, H B 131133, I/A 74 (15.02.12).
- Nombramientos
ADM.CONJUNTO: CASTELLANO SANCHEZ JUAN.
13/01/2012 Details of the advert (16001) Registry data: T 40543 , F 98, S 8, H B 131133, I/A 73 ( 2.01.12).
- Revocaciones
APODERADO: DE PEÑARANDA GONZALEZ ROBATTO MARTA;DIAZ GARCIA VIRGINIA;MARTINEZ SEQUERA JOSE.
Mercantile Registry documents related: 20
#CVE
|
Date
|
State
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2014-175-08 | 15/09/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-135-08 | 18/07/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-40-08 | 27/02/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-40-08 | 27/02/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-23-08 | 04/02/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2013-195-08 | 11/10/2013 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2013-157-08 | 20/08/2013 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-39-08 | 24/02/2012 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-39-08 | 24/02/2012 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-9-08 | 13/01/2012 | Barcelona | Descargar |