HORIZONT 1000 SL
Extinta
If you want to update or modify register for free
Last movements
| Date | Name | |
|---|---|---|
| Cese: 17/08/2018 | VICENTE MARTINEZ MARIA ROSA | Administrador único | 
| Nombramiento: 17/08/2018 | ESTANY CABEZAS JOAN | Liquidador | 
| Nombramiento: 17/08/2016 | ERANS ALBERT EMILIO | Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 18/04/2016 | SIERRA MONTOYA IVAN | Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 21/12/2015 | ALVAREZ PEREZ MANUEL BALBINO | Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 21/12/2015 | TORRECILLAS PICAZO ANTONIO | Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 21/12/2015 | RODRIGUEZ DIEZ DAVID | Apoderado solidario | 
| Cese: 09/12/2015 | GARDE GURPEGUI FERNANDO LUCIO | Administrador | 
| Nombramiento: 09/12/2015 | VICENTE MARTINEZ MARIA ROSA | Administrador único | 
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by HORIZONT 1000 SL
17/08/2018 Details of the advert (340329) Registry data: T 45485 , F 91, S 8, H B 180153, I/A 9 ( 9.08.18).
- RevocacionesADM.UNICO: VICENTE MARTINEZ MARIA ROSA. 
- NombramientosLIQUIDADOR: ESTANY CABEZAS JOAN. 
- DisoluciónVoluntaria. 
26/01/2017 Details of the advert (41087) Registry data: T 30735 , F 194, S 8, H B 180153, I/A 5 N (19.01.17).
- Otros ConceptosINHABILITACION DE DON MANUEL BALBINO ALVAREZ PEREZ,POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DICTADA EN FECHA 26/02/2015 POR EL JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA. 
17/08/2016 Details of the advert (338935) Registry data: T 30735 , F 195, S 8, H B 180153, I/A 8 ( 8.08.16).
- NombramientosAPODERAD.SOL: ERANS ALBERT EMILIO. 
18/04/2016 Details of the advert (167231) Registry data: T 30735 , F 195, S 8, H B 180153, I/A 7 ( 8.04.16).
- NombramientosAPODERAD.SOL: SIERRA MONTOYA IVAN. 
21/12/2015 Details of the advert (515125) Registry data: T 30735 , F 194, S 8, H B 180153, I/A 5 (11.12.15).
- NombramientosAPODERAD.SOL: ALVAREZ PEREZ MANUEL BALBINO. 
21/12/2015 Details of the advert (515124) Registry data: T 30735 , F 194, S 8, H B 180153, I/A 4 (11.12.15).
- NombramientosAPODERAD.SOL: TORRECILLAS PICAZO ANTONIO. 
21/12/2015 Details of the advert (515126) Registry data: T 30735 , F 195, S 8, H B 180153, I/A 6 (11.12.15).
- NombramientosAPODERAD.SOL: RODRIGUEZ DIEZ DAVID. 
09/12/2015 Details of the advert (497333) Registry data: T 30735 , F 193, S 8, H B 180153, I/A 3 (26.11.15).
- RevocacionesADMINISTR.: GARDE GURPEGUI FERNANDO LUCIO. 
- NombramientosADM.UNICO: VICENTE MARTINEZ MARIA ROSA. 
- Cambio de domicilio socialCL POMPEU FABRA Num.24 (CASTELLDEFELS). 
- Cambio de objeto socialAMPLIAR A: LA FABRICACION,IMPRESION,ENCUADERNACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y EDITORIAL.DIRIGIR Y GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES ... 
10/05/2012 Details of the advert (199555) Registry data: T 30735 , F 192, S 8, H B 180153, I/A 2 (25.04.12).
- Cambio de domicilio socialCL VALLCORBA Num.10 P.2 PTA.1 (SANT QUIRZE DEL VALLES). 
- Cambio de objeto socialAMPLIAR A:LA INTERMEDIACION EN COMERCIO Y LA REPRESENTACION DE PRODUCTOS DE TELEFONIA E INFORMATICOS,TELECOMUNICACIONES,NUEVAS TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS EN GENERAL. 
27/10/2011 Details of the advert (870400)
- Depósitos de cuentas anuales(Septiembre de 2011) Año: 2010 
Mercantile Registry documents related: 12
| #CVE | Date | State | |
|---|---|---|---|
| BORME-A-2018-158-08 | 17/08/2018 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2017-18-08 | 26/01/2017 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2016-156-08 | 17/08/2016 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2016-73-08 | 18/04/2016 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2015-242-08 | 21/12/2015 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2015-242-08 | 21/12/2015 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2015-242-08 | 21/12/2015 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2015-234-08 | 09/12/2015 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-A-2012-88-08 | 10/05/2012 | Barcelona | Descargar | 
| BORME-B-2011-205-08 | 27/10/2011 | Barcelona | Descargar | 
 
			