GRUPO EIDOS CONSULTORIA INFORMATICA SL

Extinta

CALLE ALBASANZ, 16 - PLT 4
Madrid  (28037)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 03/12/2021

DIAZ MOYA JOSE RAMON

Apoderado
Cese: 30/09/2016

DAS NATH RAMENDRA

Consejero
Cese: 30/09/2016

GUEVARA JAIME FRANCISCO

Secretario
Nombramiento: 30/09/2016

GUEVARA JAIME FRANCISCO PLINIO

Consejero
Nombramiento: 30/09/2016

GUEVARA JAIME FRANCISCO PLINIO

Secretario
Nombramiento: 10/04/2014

GRANT THORNTON SLP

Auditor
Cese: 01/03/2011

ALVES TORRES JOSE CARLOS

Apoderado
Cese: 01/03/2011

ALVES TORRES JOSE CARLOS

Apoderado
Cese: 01/03/2011

QUIROS CASADO ANTONIO

Apoderado
Cese: 05/10/2010

ALVES TORRES JOSE CARLOS

Representante
Cese: 05/10/2010

DERMONT ERIC

Consejero
Cese: 05/10/2010

ALVES TORRES JOSE CARLOS

Consejero
Cese: 05/10/2010

DERMONT ERIC

Presidente
Cese: 05/10/2010

DERMONT ERIC

Consejero delegado
Nombramiento: 05/10/2010

SEBAN GEORGES

Representante
Nombramiento: 05/10/2010

SEBAN GEORGES

Consejero
Nombramiento: 05/10/2010

SEBAN GEORGES

Consejero delegado
Nombramiento: 05/10/2010

SEBAN GEORGES

Presidente
Nombramiento: 05/10/2010

DAS NATH RAMENDRA

Consejero
Cese: 04/06/2010

GUEVARA JAIME FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 04/06/2010

GUEVARA JAIME FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 04/06/2010

DIAZ MOYA JOSE RAMON

Apoderado
Nombramiento: 02/06/2010

ALVES TORRES JOSE CARLOS

Apoderado
Cese: 27/10/2009

PEREZ SEGADO MARTIN

Apoderado
Nombramiento: 24/09/2009

ALVES TORRES JOSE CARLOS

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by GRUPO EIDOS CONSULTORIA INFORMATICA SL

26/10/2022 Details of the advert (469237) Registry data: T 1245 , F 222, S 8, H M 12050, I/A 30 (19.10.22).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

03/12/2021 Details of the advert (526093) Registry data: T 1245 , F 220, S 8, H M 12050, I/A 29 (26.11.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: DIAZ MOYA JOSE RAMON.

23/11/2017 Details of the advert (460500) Registry data: T 1245 , F 219, S 8, H M 12050, I/A 28 (16.11.17).

  • Cambio de objeto social

    Actividades de formación el campo de la informatica.

  • Escisión Parcial

    Sociedades beneficiarias de la escisión: ALHAMBRA SYSTEMS SA.

30/09/2016 Details of the advert (395272) Registry data: T 1245 , F 218, S 8, H M 12050, I/A 27 (22.09.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DAS NATH RAMENDRA. Secretario: GUEVARA JAIME FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Consejero: GUEVARA JAIME FRANCISCO PLINIO. Secretario: GUEVARA JAIME FRANCISCO PLINIO.

10/04/2014 Details of the advert (160792) Registry data: T 1245 , F 218, S 8, H M 12050, I/A 26 ( 2.04.14).

  • Nombramientos

    Auditor: GRANT THORNTON SLP.

02/08/2011 Details of the advert (234936)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

01/03/2011 Details of the advert (93028) Registry data: T 1245 , F 218, S 8, H M 12050, I/A 25 (17.02.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: ALVES TORRES JOSE CARLOS;ALVES TORRES JOSE CARLOS;QUIROS CASADO ANTONIO.

05/10/2010 Details of the advert (372347) Registry data: T 1245 , F 217, S 8, H M 12050, I/A 24 (21.09.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: ALVES TORRES JOSE CARLOS. Consejero: DERMONT ERIC;ALVES TORRES JOSE CARLOS. Presidente: DERMONT ERIC. Con.Delegado: DERMONT ERIC.

  • Nombramientos

    Representan: SEBAN GEORGES. Consejero: SEBAN GEORGES. Con.Delegado: SEBAN GEORGES. Presidente: SEBAN GEORGES. Consejero: DAS NATH RAMENDRA.

10/08/2010 Details of the advert (297214)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2009

04/06/2010 Details of the advert (222815) Registry data: T 1245 , F 216, S 8, H M 12050, I/A 23 (25.05.10).

  • Revocaciones

    Apoderado: GUEVARA JAIME FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Apoderado: GUEVARA JAIME FRANCISCO.

Mercantile Registry documents related: 15

#CVE
Date
State
BORME-A-2022-205-28 26/10/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-232-28 03/12/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2017-223-28 23/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-188-28 30/09/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-70-28 10/04/2014 Madrid Descargar
BORME-B-2011-146-28 02/08/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-41-28 01/03/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2010-192-28 05/10/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-152-28 10/08/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-105-28 04/06/2010 Madrid Descargar