GROUPE ZANNIER ESPAÑA SA

Cambio de denominación social

CALLE MALLORCA, 318 - - PISO 4º - PTA 2ª
Barcelona  (08037)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 04/01/2017

LOIC RENE FRANCIS JOSSE

Administrador solidario
Cese: 08/04/2016

RAMIS BALLABRIGA MIGUEL

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 08/04/2016

RAMIS PLANILLO JUAN

Apoderado solidario
Cese: 05/02/2016

FRANQUESA CASTRILLO CARLOS

Apoderado
Cese: 05/02/2016

PITARCH SOSPEDRA FELIPE

Apoderado
Cese: 05/02/2016

BERNARD ALEXIS MARIE MOLTER

Apoderado
Cese: 05/02/2016

JEAN PHILIPPE JOSE HENRI BOU

Apoderado
Cese: 05/02/2016

DAVID JACKY ROBERT FUGER

Apoderado
Nombramiento: 18/09/2014

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 18/09/2014

RAMIS BALLABRIGA MIGUEL

Apoderado solidario mancomunado
Cese: 18/09/2014

DAVID JACKY ROBERT FUGER

Apoderado
Nombramiento: 21/04/2014

ARNAUD JEAN CLAUDE BUFFET

Administrador solidario
Nombramiento: 21/04/2014

FRANCOISE PAULETTE MARIE COTTEREAU

Administrador solidario
Nombramiento: 21/04/2014

CHRISTOPHE OLIVIER DUBOIS

Administrador solidario
Cese: 21/04/2014

FABRIZIO LUCA CAVALLARI

Apoderado
Cese: 19/02/2013

DOMINIQUE BERNARD DURAND

Administrador solidario
Cese: 19/11/2012

JACQUES VICTOR RENE DEVAUD

Administrador solidario
Cese: 05/11/2012

LEVY COHEN ELIAS

Apoderado
Nombramiento: 05/11/2012

DAVID JACKY ROBERT FUGER

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by GROUPE ZANNIER ESPAÑA SA

23/01/2017 Details of the advert (32844) Registry data: T 38884 , F 175, S 8, H B 59332, I/A 88 (13.01.17).

  • Cambio de denominación social

    KIDILIZ GROUP KIDSWEAR SPAIN SA.

04/01/2017 Details of the advert (4333) Registry data: T 38884 , F 175, S 8, H B 59332, I/A 87 (27.12.16).

  • Nombramientos

    ADM.SOLIDAR.: LOIC RENE FRANCIS JOSSE.

08/04/2016 Details of the advert (154940) Registry data: T 38884 , F 175, S 8, H B 59332, I/A 86 (31.03.16).

  • Revocaciones

    APOD.SOL/MAN: RAMIS BALLABRIGA MIGUEL.

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: RAMIS PLANILLO JUAN.

05/02/2016 Details of the advert (51655) Registry data: T 38884 , F 175, S 8, H B 59332, I/A 85 (28.01.16).

  • Revocaciones

    APODERADO: FRANQUESA CASTRILLO CARLOS;PITARCH SOSPEDRA FELIPE;BERNARD ALEXIS MARIE MOLTER;JEAN PHILIPPE JOSE HENRI BOU;DAVID JACKY ROBERT FUGER.

18/09/2014 Details of the advert (371020) Registry data: T 38884 , F 174, S 8, H B 59332, I/A 84 ( 9.09.14).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.

18/09/2014 Details of the advert (371014) Registry data: T 38884 , F 174, S 8, H B 59332, I/A 83 ( 9.09.14).

  • Nombramientos

    APOD.SOL/MAN: RAMIS BALLABRIGA MIGUEL.

  • Modificación de poderes

    APODERADO: DAVID JACKY ROBERT FUGER.

05/09/2014 Details of the advert (356885) Registry data: T 38884 , F 172, S 8, H B 59332, I/A 82 (28.08.14).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 5.625.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.875.000,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 3.000.008,00 Euros. Desembolsado: 3.000.008,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.875.008,00 Euros. Resultante Desembolsado: 9.875.008,00 Euros.

21/04/2014 Details of the advert (171238) Registry data: T 38884 , F 172, S 8, H B 59332, I/A 80 ( 9.04.14).

  • Nombramientos

    ADM.SOLIDAR.: ARNAUD JEAN CLAUDE BUFFET;FRANCOISE PAULETTE MARIE COTTEREAU;CHRISTOPHE OLIVIER DUBOIS.

21/04/2014 Details of the advert (171239) Registry data: T 38884 , F 172, S 8, H B 59332, I/A 81 ( 9.04.14).

  • Revocaciones

    APODERADO: FABRIZIO LUCA CAVALLARI.

02/04/2013 Details of the advert (151048) Registry data: T 38884 , F 172, S 8, H B 59332, I/A 79 (18.03.13).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 6.000.000,00 Euros. Desembolsado: 6.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.500.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 12.500.000,00 Euros.

Mercantile Registry documents related: 26

#CVE
Date
State
BORME-A-2017-15-08 23/01/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-3-08 04/01/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-67-08 08/04/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-24-08 05/02/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-178-08 18/09/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-178-08 18/09/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-169-08 05/09/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-75-08 21/04/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-75-08 21/04/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-61-08 02/04/2013 Barcelona Descargar