GOLAY CODING MODULATION SL

Extinta

C/ PRIMAVERA 39 POLIGONO INDUSTRIAL LAS MONJAS (TORREJON DE ARDOZ).
 Torrejón de Ardoz, Madrid  (28850)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 09/08/2016

DUBOIS ALBERT

Consejero
Cese: 09/08/2016

RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL

Consejero
Cese: 09/08/2016

REYMUNDO IZARD FERNANDO

Consejero
Cese: 09/08/2016

DUBOIS ALBERT

Presidente
Cese: 09/08/2016

RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL

Secretario
Cese: 16/07/2014

MARTIN SUAREZ MARIA DEL PILAR

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2013

DUBOIS ALBERT

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 20/05/2013

REYMUNDO IZARD FERNANDO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 20/05/2013

RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL

Apoderado mancomunado
Cese: 17/05/2013

DIAZ FUENTE VICENTE

Consejero
Cese: 17/05/2013

DIAZ FUENTE VICENTE

Presidente
Cese: 17/05/2013

VALLEJO URBANO JORDI

Consejero
Cese: 17/05/2013

DUBOIS ALBERT

Secretario
Nombramiento: 17/05/2013

DUBOIS ALBERT

Presidente
Nombramiento: 17/05/2013

RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL

Secretario
Cese: 25/11/2011

DIAZ FUENTE VICENTE

Consejero delegado
Cese: 25/11/2011

FERNANDEZ MARTIN OSCAR-ANTONIO

Consejero
Cese: 25/11/2011

MARTIN SUAREZ MARIA DEL PILAR

Consejero
Nombramiento: 25/11/2011

VALLEJO URBANO JORDI

Consejero
Nombramiento: 25/11/2011

REYMUNDO IZARD FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 22/09/2010

FERNANDEZ MARTIN OSCAR-ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 22/09/2010

MARTIN SUAREZ MARIA DEL PILAR

Consejero
Cese: 25/03/2010

DE BELAUSTEGUIGOITIA MATEACHE ENEKO-PEDRO

Apoderado solidario
Cese: 25/03/2010

PEÑA RAMILO ANGEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 25/03/2010

DIAZ FUENTE VICENTE

Consejero delegado
Cese: 03/02/2010

NAUTA TECH INVEST II SCR SOCIEDAD DE REGIMEN SIMPL

Consejero
Cese: 03/02/2010

NAUTA TECH INVEST II SCR SOCIEDAD DE REGIMEN SIMPL

Secretario
Cese: 03/02/2010

SANCHEZ JIMENEZ DANIEL

Representante
Nombramiento: 03/02/2010

DUBOIS ALBERT

Secretario
Cese: 04/12/2009

SANCHEZ MARTINEZ SERGIO

Consejero
Nombramiento: 22/05/2009

MARTIN SUAREZ MARIA DEL PILAR

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by GOLAY CODING MODULATION SL

09/08/2016 Details of the advert (328649) Registry data: T 31071 , F 140, S 8, H M 288069, I/A 25 ( 2.08.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DUBOIS ALBERT;RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL;REYMUNDO IZARD FERNANDO. Presidente: DUBOIS ALBERT. Secretario: RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 55/2015. FIRME: Si, Fecha de resolución 13/10/2015. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 8 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: MARIA DE GRACIA PARERA DE CACERES. Resoluciones: AUTO FIRME POR EL QUE SE DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO A LA SOCIEDAD GOLAY CODING MODULATION SL, Y SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 55/2015. FIRME: Si, Fecha de resolución 13/10/2016. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 8 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: MARIA DE GRACIA PARERA DE CACERES.

  • Extinción

16/07/2014 Details of the advert (293911) Registry data: T 31071 , F 140, S 8, H M 288069, I/A 24 ( 7.07.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: MARTIN SUAREZ MARIA DEL PILAR.

13/09/2013 Details of the advert (398763) Registry data: T 31071 , F 139, S 8, H M 288069, I/A 23 ( 5.09.13).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 51.356,00 Euros. Resultante Suscrito: 237.310,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 415.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 652.310,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.- .Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.

  • Cambio de domicilio social

    C/ PRIMAVERA 39 POLIGONO INDUSTRIAL LAS MONJAS (TORREJON DE ARDOZ).

27/06/2013 Details of the advert (294131) Registry data: T 16853 , F 225, S 8, H M 288069, I/A 22 (19.06.13).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 22.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 185.954,00 Euros.

20/05/2013 Details of the advert (227557) Registry data: T 16853 , F 222, S 8, H M 288069, I/A 21 ( 9.05.13).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: DUBOIS ALBERT. Apo.Manc.: REYMUNDO IZARD FERNANDO;RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL.

17/05/2013 Details of the advert (225496) Registry data: T 16853 , F 222, S 8, H M 288069, I/A 20 ( 9.05.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DIAZ FUENTE VICENTE. Presidente: DIAZ FUENTE VICENTE. Consejero: VALLEJO URBANO JORDI. Secretario: DUBOIS ALBERT.

  • Nombramientos

    Presidente: DUBOIS ALBERT. Secretario: RODENAS SANTIAGO JUAN RAFAEL.

24/01/2012 Details of the advert (32877) Registry data: T 16853 , F 220, S 8, H M 288069, I/A 19 (10.01.12).

  • Modificaciones Estatutarias

    DEROGADOS LOS ACTUALES ESTATUTOS SOCIALES Y APROBADO UN NUEVO TEXTO DE ESTATUTOS SOCIALES.

25/11/2011 Details of the advert (472655) Registry data: T 16853 , F 220, S 8, H M 288069, I/A 18 (16.11.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: DIAZ FUENTE VICENTE. Consejero: FERNANDEZ MARTIN OSCAR-ANTONIO;MARTIN SUAREZ MARIA DEL PILAR.

  • Nombramientos

    Consejero: VALLEJO URBANO JORDI;REYMUNDO IZARD FERNANDO.

01/07/2011 Details of the advert (278802) Registry data: T 16853 , F 219, S 8, H M 288069, I/A 17 (15.06.11).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 21.598,00 Euros. Resultante Suscrito: 162.004,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 163.204,00 Euros.

30/06/2011 Details of the advert (188891)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2011) Año: 2010

Mercantile Registry documents related: 21

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-151-28 09/08/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-133-28 16/07/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-175-28 13/09/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-120-28 27/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-92-28 20/05/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-91-28 17/05/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-16-28 24/01/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-224-28 25/11/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-125-28 01/07/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2011-124-28 30/06/2011 Madrid Descargar