GLOBAL COLQUIDA SL

Extinta

C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 12 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 17/07/2019

SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 2 SA

Administrador único
Cese: 17/07/2019

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Cese: 17/07/2019

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL

Apoderado solidario
Cese: 17/07/2019

GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE

Apoderado solidario
Cese: 01/07/2019

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Cese: 01/07/2019

GLOBAL BENENGELI SL

Administrador único
Cese: 01/07/2019

OLAGUIBEL AMICH IÑIGO

Apoderado solidario
Cese: 01/07/2019

VALENCIA MUÑOZ PABLO

Apoderado solidario
Cese: 01/07/2019

ASUERO RESUSTA VICENTE

Apoderado solidario
Cese: 01/07/2019

GIMENEZ SORIANO PABLO

Apoderado solidario
Cese: 01/07/2019

PAREJO DEL RIO DANIEL

Apoderado solidario
Cese: 01/07/2019

PEREZ MARCOS OSCAR

Apoderado solidario
Nombramiento: 01/07/2019

SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 2 SA

Administrador único
Nombramiento: 01/07/2019

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Nombramiento: 01/07/2019

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 01/07/2019

GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE

Apoderado solidario
Cese: 24/10/2017

SANTIAGO PEREZ ANTONIO

Administrador único
Nombramiento: 24/10/2017

GLOBAL BENENGELI SL

Administrador único
Nombramiento: 24/10/2017

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Nombramiento: 24/10/2017

OLAGUIBEL AMICH IÑIGO

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/10/2017

VALENCIA MUÑOZ PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/10/2017

ASUERO RESUSTA VICENTE

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/10/2017

GIMENEZ SORIANO PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/10/2017

PAREJO DEL RIO DANIEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/10/2017

PEREZ MARCOS OSCAR

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/09/2017

SANTIAGO PEREZ ANTONIO

Administrador único

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by GLOBAL COLQUIDA SL

17/07/2019 Details of the advert (307924) Registry data: T 39264 , F 94, S 8, H M 652375, I/A 7 (10.07.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 2 SA. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

01/07/2019 Details of the advert (283376) Registry data: T 36309 , F 9, S 8, H M 652375, I/A 6 (24.06.19).

  • Sociedad Unipersonal

    SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 2 SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL. Adm. Unico: GLOBAL BENENGELI SL.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: OLAGUIBEL AMICH IÑIGO;VALENCIA MUÑOZ PABLO;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL;PEREZ MARCOS OSCAR.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 2 SA. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.

  • Cambio de domicilio social

    C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 12 (MADRID).

22/02/2018 Details of the advert (86293) Registry data: T 36309 , F 8, S 8, H M 652375, I/A 5 (13.02.18).

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO UNO SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO DOS SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO TRES SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO CUATRO SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO CINCO SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO SEIS SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO SIETE SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO OCHO SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO NUEVE SL. PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO DIEZ SL.

24/10/2017 Details of the advert (417568) Registry data: T 36309 , F 8, S 8, H M 652375, I/A 4 (16.10.17).

  • Sociedad Unipersonal

    GLOBAL BENENGELI SL.

24/10/2017 Details of the advert (417270) Registry data: T 36309 , F 3, S 8, H M 652375, I/A 2 (16.10.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GLOBAL BENENGELI SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social y web corporativa.-.

  • Cambio de domicilio social

    C/ JENNER 3 4ª (MADRID).

24/10/2017 Details of the advert (417271) Registry data: T 36309 , F 4, S 8, H M 652375, I/A 3 (16.10.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: OLAGUIBEL AMICH IÑIGO;VALENCIA MUÑOZ PABLO;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL;PEREZ MARCOS OSCAR.

04/09/2017 Details of the advert (357979) Registry data: T 36309 , F 1, S 8, H M 652375, I/A 1 (24.08.17).

  • Constitución

    Comienzo de operaciones: 8.08.17. Objeto social: La tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas e instrumentos financieros, respetando, en todo, la normativa de la Ley del Mercado de Valores. 2. La prestación y gestión de servicios administrativos, de contabilidad,. Domicilio: C/ PRADILLO Nº 5, BAJO EXTERIOR, DERECHA (MADRID). Capital: 3.600,00 Euros.

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO.

Mercantile Registry documents related: 7

#CVE
Date
State
BORME-A-2019-135-28 17/07/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-123-28 01/07/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-38-28 22/02/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-203-28 24/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-203-28 24/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-203-28 24/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-168-28 04/09/2017 Madrid Descargar