GAUDIR ILLUMINACIO SL

Activa

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 27/06/2018

AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP

Auditor
Cese: 22/12/2016

ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA

Consejero
Cese: 22/12/2016

ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA

Presidente
Cese: 22/12/2016

ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 22/12/2016

ALBERTO LOMERO FRANCO

Consejero
Cese: 22/12/2016

ALBERTO LOMERO FRANCO

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 22/12/2016

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Consejero
Cese: 22/12/2016

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 22/12/2016

ANTONI BRUGAROLA PUJOL

Consejero
Cese: 22/12/2016

ANTONI BRUGAROLA PUJOL

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 22/12/2016

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Secretario
Nombramiento: 22/12/2016

ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA

Consejero
Nombramiento: 22/12/2016

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Consejero
Nombramiento: 22/12/2016

ALBERTO LOMERO FRANCO

Consejero
Nombramiento: 22/12/2016

ANTONI BRUGAROLA PUJOL

Consejero
Nombramiento: 22/12/2016

ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA

Presidente
Nombramiento: 22/12/2016

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Secretario
Nombramiento: 22/12/2016

ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 22/12/2016

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 22/12/2016

ALBERTO LOMERO FRANCO

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 22/12/2016

ANTONI BRUGAROLA PUJOL

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 02/11/2015

MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL

Consejero
Cese: 02/11/2015

MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL

Secretario
Cese: 02/11/2015

MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 02/11/2015

ANTONI BRUGAROLA PUJOL

Consejero
Nombramiento: 02/11/2015

ANTONI BRUGAROLA PUJOL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 02/11/2015

JOSEP BRUGAROLA PUJOL

Secretario
Nombramiento: 20/07/2010

AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by GAUDIR ILLUMINACIO SL

27/06/2018 Details of the advert (269271) Registry data: T 3002 , F 41, S 8, H GI 2936, I/A 14 (20.06.18).

  • Reelecciones

    Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP.

22/12/2016 Details of the advert (518927) Registry data: T 3002 , F 40, S 8, H GI 2936, I/A 12 (15.12.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA. Presidente: ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA. Co.De.Ma.So: ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA. Consejero: ALBERTO LOMERO FRANCO. Co.De.Ma.So: ALBERTO LOMERO FRANCO. Consejero: JOSEP BRUGAROLA PUJOL. Co.De.Ma.So: JOSEP BRUGAROLA PUJOL. Consejero: ANTONI BRUGAROLA PUJOL. Co.De.Ma.So: ANTONI BRUGAROLA PUJOL. Secretario: JOSEP BRUGAROLA PUJOL.

  • Nombramientos

    Consejero: ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA;JOSEP BRUGAROLA PUJOL;ALBERTO LOMERO FRANCO;ANTONI BRUGAROLA PUJOL. Presidente: ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA. Secretario: JOSEP BRUGAROLA PUJOL. Co.De.Ma.So: ALFONSO MARTINEZ CUSCURITA;JOSEP BRUGAROLA PUJOL;ALBERTO LOMERO FRANCO;ANTONI BRUGAROLA PUJOL.

02/11/2015 Details of the advert (439709) Registry data: T 3002 , F 40, S 8, H GI 2936, I/A 11 (23.10.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL. Secretario: MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL. Co.De.Ma.So: MARIA DOLORS BRUGAROLA PUJOL.

  • Nombramientos

    Consejero: ANTONI BRUGAROLA PUJOL. Co.De.Ma.So: ANTONI BRUGAROLA PUJOL. Secretario: JOSEP BRUGAROLA PUJOL.

19/12/2014 Details of the advert (518422) Registry data: T 1004 , F 37, S 8, H GI 2936, I/A 10 (11.12.14).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 160.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 68.600,00 Euros.

  • Escisión Parcial

    Sociedades beneficiarias de la escisión: ZENIT BLM SOCIEDAD LIMITADA.

31/01/2012 Details of the advert (47111) Registry data: T 1004 , F 36, S 8, H GI 2936, I/A 9 (20.01.12).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 68.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 228.600,00 Euros.

27/12/2011 Details of the advert (516643) Registry data: T 1004 , F 36, S 8, H GI 2936, I/A 8 (15.12.11).

  • Ampliación del Objeto Social

    Así como la realización de toda clase de operaciones inmobiliarias; compraventa y permuta de fincas rústicas y urbanas; la urbanización de terrenos yejecución de todo tipo de obras; la construcción de toda clase de edificaciones, su venta, explotación directa o cesión en arrendamiento.

29/08/2011 Details of the advert (377074)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

13/08/2010 Details of the advert (314815)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010) Año: 2009

20/07/2010 Details of the advert (284613) Registry data: T 1004 , F 36, S 8, H GI 2936, I/A 6 ( 9.07.10).

  • Nombramientos

    Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP.

04/01/2010 Details of the advert (488)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 10

#CVE
Date
State
BORME-A-2018-122-17 27/06/2018 Girona Descargar
BORME-A-2016-242-17 22/12/2016 Girona Descargar
BORME-A-2015-209-17 02/11/2015 Girona Descargar
BORME-A-2014-242-17 19/12/2014 Girona Descargar
BORME-A-2012-21-17 31/01/2012 Girona Descargar
BORME-A-2011-244-17 27/12/2011 Girona Descargar
BORME-B-2011-164-17 29/08/2011 Girona Descargar
BORME-B-2010-155-17 13/08/2010 Girona Descargar
BORME-A-2010-137-17 20/07/2010 Girona Descargar
BORME-B-2010-1-17 04/01/2010 Girona Descargar