EXPLOTACIONES GALLEGAS SL

Activa

LUGAR CEBREIRO SAN XIAO, S/N
 Pino, O, Coruña, A  (15821)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 18/12/2020

GOMEZ PORTELA EVA

Administrador solidario
Nombramiento: 18/12/2020

CASIÑAS SL

Administrador solidario
Nombramiento: 23/06/2015

GOMEZ PORTELA EVA

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/06/2015

LOPEZ MARTIN ALBERTO

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/06/2015

BELOSO COPA FERNANDO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 23/06/2015

RICO GARABITO CARLOS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 23/06/2015

VILA FEIJOO JORGE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 23/06/2015

BELOSO COPA FERNANDO

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/06/2015

RICO GARABITO CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/06/2015

VILA FEIJOO JORGE

Apoderado solidario
Nombramiento: 19/01/2012

AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA

Auditor
Cese: 27/03/2009

GOMEZ PORTELA FRANCISCO

Administrador solidario
Nombramiento: 27/03/2009

GOMEZ PORTELA EVA

Administrador solidario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by EXPLOTACIONES GALLEGAS SL

11/01/2022 Details of the advert (10308) Registry data: T 45 , F 84, S 8, H SC 8029, I/A 18 (31.12.21).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 18.721,53 Euros. Resultante Suscrito: 439.430,00 Euros.

18/12/2020 Details of the advert (448381) Registry data: T 45 , F 84, S 8, H SC 8029, I/A 17 (11.12.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: GOMEZ PORTELA EVA.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: CASIÑAS SL.

16/03/2016 Details of the advert (121002) Registry data: T 45 , F 83, S 8, H SC 8029, I/A 16 (29.02.16).

  • Pérdida del carácter de unipersonalidad

20/01/2016 Details of the advert (22001) Registry data: T 45 , F 83, S 8, H SC 8029, I/A 15 ( 8.01.16).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    CASIÑAS SL.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 180.303,63 Euros. Resultante Suscrito: 420.708,47 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: Artículo 5. El capital social se fija en 420.708,47.- E -cuatrocientos veinte mil setecientos ocho euros con cuarenta y siete céntimos-, representado y dividido en 14.000 - catorce mil- participaciones sociales con un valor nominal de 30,050605.- E -treinta euros con.

  • Otros Conceptos

    Renumeración de las participaciones sociales.-

23/06/2015 Details of the advert (256732) Registry data: T 45 , F 82, S 8, H SC 8029, I/A 14 (16.06.15).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: GOMEZ PORTELA EVA;LOPEZ MARTIN ALBERTO. Apo.Manc.: BELOSO COPA FERNANDO;RICO GARABITO CARLOS;VILA FEIJOO JORGE. Apo.Sol.: BELOSO COPA FERNANDO;RICO GARABITO CARLOS;VILA FEIJOO JORGE.

19/01/2012 Details of the advert (25822) Registry data: T 45 , F 82, S 8, H SC 8029, I/A 13 ( 3.01.12).

  • Reelecciones

    Auditor: AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA.

29/08/2011 Details of the advert (376167)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011)

03/09/2010 Details of the advert (438316)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010)

03/09/2010 Details of the advert (438563)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010)

25/08/2009 Details of the advert (250123)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2009)

Mercantile Registry documents related: 11

#CVE
Date
State
BORME-A-2022-6-15 11/01/2022 Coruña, A Descargar
BORME-A-2020-242-15 18/12/2020 Coruña, A Descargar
BORME-A-2016-52-15 16/03/2016 Coruña, A Descargar
BORME-A-2016-12-15 20/01/2016 Coruña, A Descargar
BORME-A-2015-116-15 23/06/2015 Coruña, A Descargar
BORME-A-2012-13-15 19/01/2012 Coruña, A Descargar
BORME-B-2011-164-15 29/08/2011 Coruña, A Descargar
BORME-B-2010-170-15 03/09/2010 Coruña, A Descargar
BORME-B-2010-170-15 03/09/2010 Coruña, A Descargar
BORME-B-2009-161-15 25/08/2009 Coruña, A Descargar