EXPLOTACIONES GALLEGAS SL
Activa
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 18/12/2020 | GOMEZ PORTELA EVA |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 18/12/2020 | CASIÑAS SL |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 23/06/2015 | GOMEZ PORTELA EVA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 23/06/2015 | LOPEZ MARTIN ALBERTO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 23/06/2015 | BELOSO COPA FERNANDO |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 23/06/2015 | RICO GARABITO CARLOS |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 23/06/2015 | VILA FEIJOO JORGE |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 23/06/2015 | BELOSO COPA FERNANDO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 23/06/2015 | RICO GARABITO CARLOS |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 23/06/2015 | VILA FEIJOO JORGE |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 19/01/2012 | AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA |
Auditor |
| Cese: 27/03/2009 | GOMEZ PORTELA FRANCISCO |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 27/03/2009 | GOMEZ PORTELA EVA |
Administrador solidario |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by EXPLOTACIONES GALLEGAS SL
11/01/2022 Details of the advert (10308) Registry data: T 45 , F 84, S 8, H SC 8029, I/A 18 (31.12.21).
- Ampliación de Capital
Capital: 18.721,53 Euros. Resultante Suscrito: 439.430,00 Euros.
18/12/2020 Details of the advert (448381) Registry data: T 45 , F 84, S 8, H SC 8029, I/A 17 (11.12.20).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Solid.: GOMEZ PORTELA EVA.
- Nombramientos
Adm. Solid.: CASIÑAS SL.
16/03/2016 Details of the advert (121002) Registry data: T 45 , F 83, S 8, H SC 8029, I/A 16 (29.02.16).
- Pérdida del carácter de unipersonalidad
20/01/2016 Details of the advert (22001) Registry data: T 45 , F 83, S 8, H SC 8029, I/A 15 ( 8.01.16).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
CASIÑAS SL.
- Reducción de Capital
Importe reducción: 180.303,63 Euros. Resultante Suscrito: 420.708,47 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: Artículo 5. El capital social se fija en 420.708,47.- E -cuatrocientos veinte mil setecientos ocho euros con cuarenta y siete céntimos-, representado y dividido en 14.000 - catorce mil- participaciones sociales con un valor nominal de 30,050605.- E -treinta euros con.
- Otros Conceptos
Renumeración de las participaciones sociales.-
23/06/2015 Details of the advert (256732) Registry data: T 45 , F 82, S 8, H SC 8029, I/A 14 (16.06.15).
- Nombramientos
Apo.Sol.: GOMEZ PORTELA EVA;LOPEZ MARTIN ALBERTO. Apo.Manc.: BELOSO COPA FERNANDO;RICO GARABITO CARLOS;VILA FEIJOO JORGE. Apo.Sol.: BELOSO COPA FERNANDO;RICO GARABITO CARLOS;VILA FEIJOO JORGE.
19/01/2012 Details of the advert (25822) Registry data: T 45 , F 82, S 8, H SC 8029, I/A 13 ( 3.01.12).
- Reelecciones
Auditor: AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA.
29/08/2011 Details of the advert (376167)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2011)
03/09/2010 Details of the advert (438316)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2010)
03/09/2010 Details of the advert (438563)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2010)
25/08/2009 Details of the advert (250123)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2009)
Mercantile Registry documents related: 11
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-6-15 | 11/01/2022 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2020-242-15 | 18/12/2020 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2016-52-15 | 16/03/2016 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2016-12-15 | 20/01/2016 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2015-116-15 | 23/06/2015 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2012-13-15 | 19/01/2012 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2011-164-15 | 29/08/2011 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2010-170-15 | 03/09/2010 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2010-170-15 | 03/09/2010 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2009-161-15 | 25/08/2009 | Coruña, A | Descargar |