EDIFICIOS Y CHALETS NUEVA CATALUÑA SA

Extinta

C/ PEDRO MARIA RIC 12 1º B (ZARAGOZA).
Zaragoza
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 21/04/2021

CAMPO GALVE JOSE MANUEL

Administrador único
Nombramiento: 21/04/2021

CAMPO GALVE JOSE MANUEL

Liquidador
Nombramiento: 14/02/2020

CAMPO GALVE JOSE MANUEL

Administrador único
Cese: 18/02/2014

FORCEN MARQUEZ JUAN

Apoderado mancomunado
Cese: 10/06/2013

FORCEN MARQUEZ JUAN

Presidente
Cese: 10/06/2013

MOLINA GARCIA ALICIA

Consejero
Cese: 10/06/2013

CAI INMUEBLES SA

Consejero
Cese: 10/06/2013

LAMELAS MARTIN MARIA BELEN

Secretario no consejero
Cese: 10/06/2013

FORCEN MARQUEZ JUAN

Consejero
Cese: 10/06/2013

RATON RAMAS JAVIER

Apoderado mancomunado
Cese: 10/06/2013

MOLINA GARCIA ALICIA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 10/06/2013

CAMPO GALVE JOSE MANUEL

Administrador único
Cese: 25/05/2011

CASTILLO MALO MIGUEL ANGEL

Consejero
Cese: 25/05/2011

CASTILLO MALO MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado
Cese: 14/09/2010

FORCEN MARQUEZ JUAN

Apoderado mancomunado
Cese: 14/09/2010

CASTILLO MALO MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado
Cese: 14/09/2010

IGLESIAS GARIJO JUAN ANTONIO

Apoderado mancomunado
Cese: 14/09/2010

MOLINA GARCIA ALICIA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/09/2010

FORCEN MARQUEZ JUAN

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/09/2010

CASTILLO MALO MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/09/2010

RATON RAMAS JAVIER

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/09/2010

MOLINA GARCIA ALICIA

Apoderado mancomunado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by EDIFICIOS Y CHALETS NUEVA CATALUÑA SA

21/04/2021 Details of the advert (182178) Registry data: T 3538 , F 71, S 8, H Z 33306, I/A 35 (14.04.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: CAMPO GALVE JOSE MANUEL.

  • Nombramientos

    Liquidador: CAMPO GALVE JOSE MANUEL.

  • Disolución

    Voluntaria.

14/02/2020 Details of the advert (70877) Registry data: T 3538 , F 71, S 8, H Z 33306, I/A 34 (10.02.20).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: CAMPO GALVE JOSE MANUEL.

18/02/2014 Details of the advert (77160) Registry data: T 3538 , F 71, S 8, H Z 33306, I/A 33 (11.02.14).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: FORCEN MARQUEZ JUAN.

10/06/2013 Details of the advert (265654) Registry data: T 3538 , F 71, S 8, H Z 33306, I/A 32 ( 3.06.13).

  • Cambio de domicilio social

    C/ PEDRO MARIA RIC 12 1º B (ZARAGOZA).

10/06/2013 Details of the advert (265653) Registry data: T 3538 , F 70, S 8, H Z 33306, I/A 31 ( 3.06.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero: MOLINA GARCIA ALICIA;CAI INMUEBLES SA. SecreNoConsj: LAMELAS MARTIN MARIA BELEN. Consejero: FORCEN MARQUEZ JUAN.

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: RATON RAMAS JAVIER;MOLINA GARCIA ALICIA.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: CAMPO GALVE JOSE MANUEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Artículo 16. 1) La Sociedad se regirá por los acuerdos de la Junta General de socios, atribuyéndose a ésta la facultad de optar alternativamente por unocualquiera de los sistemas de administración y representación que a continuación se detallan. a) Por medio de varios ADMINISTRADORES SOLIDARIOS Los párrafos primero y segundo del ARTICULO 28º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES que tendrán la siguiente nueva redacción: Artículo 28: La representación de la sociedad en juicio y fuera de él corresponde, al administrador único, a los administradores solidarios o mancomunados o al Consejo de.

  • Cambio de domicilio social

    AVDA GOMEZ LAGUNA 56 11º B (ZARAGOZA).

15/01/2013 Details of the advert (19009) Registry data: T 3538 , F 70, S 8, H Z 33306, I/A 30 ( 8.01.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 13.185.740,00 Euros. Resultante Suscrito: 66.260,00 Euros.

08/09/2011 Details of the advert (469918)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

25/05/2011 Details of the advert (223453) Registry data: T 3538 , F 70, S 8, H Z 33306, I/A 29 (13.05.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CASTILLO MALO MIGUEL ANGEL.

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: CASTILLO MALO MIGUEL ANGEL.

25/05/2011 Details of the advert (223452) Registry data: T 3538 , F 70, S 8, H Z 33306, I/A 28 (13.05.11).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 384.000,00 Euros. Desembolsado: 384.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.252.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 13.252.000,00 Euros.

28/09/2010 Details of the advert (700864)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

Mercantile Registry documents related: 20

#CVE
Date
State
BORME-A-2021-74-50 21/04/2021 Zaragoza Descargar
BORME-A-2020-31-50 14/02/2020 Zaragoza Descargar
BORME-A-2014-33-50 18/02/2014 Zaragoza Descargar
BORME-A-2013-107-50 10/06/2013 Zaragoza Descargar
BORME-A-2013-107-50 10/06/2013 Zaragoza Descargar
BORME-A-2013-9-50 15/01/2013 Zaragoza Descargar
BORME-B-2011-172-50 08/09/2011 Zaragoza Descargar
BORME-A-2011-99-50 25/05/2011 Zaragoza Descargar
BORME-A-2011-99-50 25/05/2011 Zaragoza Descargar
BORME-B-2010-187-50 28/09/2010 Zaragoza Descargar