DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE SL

Extinta

PLAZA DA VEIGA DA EIRA 1 E-2 Bl.D 1º - OFICINA 6 (PONTEVEDRA).
Pontevedra
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 23/01/2020

AUDITORES DE FINANZAS Y ASOCIADOS SL

Auditor
Cese: 23/04/2018

MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL

Consejero
Cese: 23/04/2018

GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Consejero
Cese: 23/04/2018

VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE

Consejero
Cese: 23/04/2018

MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL

Presidente
Cese: 23/04/2018

GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Vicepresidente
Cese: 23/04/2018

VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE

Secretario
Nombramiento: 23/04/2018

GALLEGA DE AUTOMACION SL

Administrador único
Cese: 05/04/2018

VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE

Apoderado
Nombramiento: 26/01/2018

AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL

Auditor
Nombramiento: 04/12/2017

RIVAS PINTOS MARIA JESUS

Apoderado
Nombramiento: 20/06/2017

MONTES COSTAS JOAQUIN

Apoderado
Cese: 03/11/2016

RIVAS BAO MANUEL

Consejero
Cese: 03/06/2016

VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE

Consejero delegado
Nombramiento: 29/04/2016

GONZALEZ ALONSO ADRIAN

Apoderado
Nombramiento: 05/01/2015

AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE SL

10/09/2020 Details of the advert (306072) Registry data: T 2668, L 2668, F 210, S 8, H PO 29290, I/A 20 ( 3.09.20).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

16/06/2020 Details of the advert (183504) Registry data: T 2668, L 2668, F 210, S 8, H PO 29290, I/A 19 ( 8.06.20).

  • Cambio de domicilio social

    PLAZA DA VEIGA DA EIRA 1 E-2 Bl.D 1º - OFICINA 6 (PONTEVEDRA).

26/02/2020 Details of the advert (89449) Registry data: T 2668, L 2668, F 210, S 8, H PO 29290, I/A 18 (18.02.20).

  • Otros Conceptos

    Se INCLUYE un nuevo ARTICULO 10 BIS a los Estatutos Sociales relativo a la prenda de participaciones.

23/01/2020 Details of the advert (30248) Registry data: T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO 29290, I/A 17 (16.01.20).

  • Nombramientos

    Auditor: AUDITORES DE FINANZAS Y ASOCIADOS SL.

23/04/2018 Details of the advert (177496) Registry data: T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO 29290, I/A 16 (13.04.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL;GONZALEZ GONZALEZ MANUEL;VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE. Presidente: MONTES COMERCIAL TECNICA DE OFICINAS SL. Vicepresid.: GONZALEZ GONZALEZ MANUEL. Secretario: VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GALLEGA DE AUTOMACION SL.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

05/04/2018 Details of the advert (152534) Registry data: T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO 29290, I/A 15 (26.03.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Apoderado: VAZQUEZ TOME VICTOR JOSE.

26/01/2018 Details of the advert (42765) Registry data: T 2668, L 2668, F 137, S 8, H PO 29290, I/A 14 (17.01.18).

  • Reelecciones

    Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL.

04/12/2017 Details of the advert (476691) Registry data: T 2668, L 2668, F 136, S 8, H PO 29290, I/A 13 (24.11.17).

  • Nombramientos

    Apoderado: RIVAS PINTOS MARIA JESUS.

20/06/2017 Details of the advert (255018) Registry data: T 2668, L 2668, F 135, S 8, H PO 29290, I/A 12 (12.06.17).

  • Nombramientos

    Apoderado: MONTES COSTAS JOAQUIN.

03/11/2016 Details of the advert (443758) Registry data: T 2668, L 2668, F 135, S 8, H PO 29290, I/A 11 (25.10.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: RIVAS BAO MANUEL.

Mercantile Registry documents related: 15

#CVE
Date
State
BORME-A-2020-176-36 10/09/2020 Pontevedra Descargar
BORME-A-2020-114-36 16/06/2020 Pontevedra Descargar
BORME-A-2020-39-36 26/02/2020 Pontevedra Descargar
BORME-A-2020-15-36 23/01/2020 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-78-36 23/04/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-66-36 05/04/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-19-36 26/01/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2017-230-36 04/12/2017 Pontevedra Descargar
BORME-A-2017-115-36 20/06/2017 Pontevedra Descargar
BORME-A-2016-210-36 03/11/2016 Pontevedra Descargar