DIRECTPRINT GRAFICA SL

Extinta

C/ FRANCIA 8 - PORTAL 7, 3º IZQUIERDA (POZUELO DE ALARCON).
 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 23/01/2019

YERRO YERRO FELIX

Apoderado
Nombramiento: 13/01/2015

ALDEGUNDE VILLANUEVA FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Cese: 17/12/2014

GARCIA DE VAL JOSE LUIS

Administrador único
Nombramiento: 17/12/2014

ORTEGA MENENDEZ MIGUEL

Administrador único
Cese: 23/06/2014

MAILTECK SA

Administrador único
Nombramiento: 23/06/2014

GARCIA DE VAL JOSE LUIS

Administrador único
Cese: 09/04/2013

CHAMORRO ORTEGA MARIA MAR

Apoderado
Cese: 09/04/2013

ROMERO PAZ YLIANA MARIA

Apoderado
Nombramiento: 04/02/2010

ROMERO PAZ YLIANA MARIA

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by DIRECTPRINT GRAFICA SL

19/07/2022 Details of the advert (335847) Registry data: T 34359 , F 42, S 8, H M 618059, I/A 4 (12.07.22).

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 175/2022. FIRME: Si, Fecha de resolución 26/05/2022. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID. Juez: BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO. Resoluciones: DECLARACION DE CONCURSO.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 175/2022. FIRME: Si, Fecha de resolución 26/05/2022. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID. Juez: BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO. Resoluciones: CONCLUSION DE CONCURSO.

  • Extinción

23/01/2019 Details of the advert (30056) Registry data: T 34359 , F 41, S 8, H M 618059, I/A 3 (16.01.19).

  • Revocaciones

    Apoderado: YERRO YERRO FELIX.

10/02/2016 Details of the advert (59976) Registry data: T 34359 , F 41, S 8, H M 618059, I/A 2 ( 2.02.16).

  • Cambio de domicilio social

    C/ FRANCIA 8 - PORTAL 7, 3º IZQUIERDA (POZUELO DE ALARCON).

13/01/2015 Details of the advert (10093) Registry data: T 1372 , F 218, S 8, H NA 27295, I/A 10 ( 2.01.15).

  • Sociedad Unipersonal

    ORTEGA MENENDEZ MIGUEL.

13/01/2015 Details of the advert (10092) Registry data: T 1372 , F 217, S 8, H NA 27295, I/A 9 ( 2.01.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: ALDEGUNDE VILLANUEVA FRANCISCO JAVIER.

17/12/2014 Details of the advert (514457) Registry data: T 1372 , F 217, S 8, H NA 27295, I/A 8 ( 1.12.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GARCIA DE VAL JOSE LUIS.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: ORTEGA MENENDEZ MIGUEL.

23/06/2014 Details of the advert (259213) Registry data: T 1372 , F 216, S 8, H NA 27295, I/A 7 ( 5.06.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: MAILTECK SA.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GARCIA DE VAL JOSE LUIS.

09/04/2013 Details of the advert (166533) Registry data: T 1372 , F 216, S 8, H NA 27295, I/A 5 (27.03.13).

  • Otros Conceptos

    CAMBIADA la denominación del Administrador unico y socio único, la mercantil MAILGRAFICA DIRECT, S.A. que pasa a ser MAILTECK, S.A..

09/04/2013 Details of the advert (166534) Registry data: T 1372 , F 216, S 8, H NA 27295, I/A 6 (27.03.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: CHAMORRO ORTEGA MARIA MAR;ROMERO PAZ YLIANA MARIA.

08/07/2011 Details of the advert (198057)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2011) Año: 2010

Mercantile Registry documents related: 14

#CVE
Date
State
BORME-A-2022-137-28 19/07/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2019-15-28 23/01/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2016-27-28 10/02/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-7-31 13/01/2015 Navarra Descargar
BORME-A-2015-7-31 13/01/2015 Navarra Descargar
BORME-A-2014-240-31 17/12/2014 Navarra Descargar
BORME-A-2014-116-31 23/06/2014 Navarra Descargar
BORME-A-2013-66-31 09/04/2013 Navarra Descargar
BORME-A-2013-66-31 09/04/2013 Navarra Descargar
BORME-B-2011-130-31 08/07/2011 Navarra Descargar