DEVA RENOVABLES SL

Extinta

C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 - PLANTA 12 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 07/02/2020

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 07/02/2020

GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 07/02/2020

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 04/02/2020

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Apoderado
Cese: 04/02/2020

NOBLE III JAMES KENDRICK

Apoderado
Cese: 04/02/2020

FURSTEIN MARC KEITH

Apoderado
Cese: 04/02/2020

SILVERS SCOTT J

Apoderado
Cese: 04/02/2020

BROOKE SORKIN JENNIFER

Apoderado
Cese: 04/02/2020

BENDITO PRIETO CARLOS

Apoderado solidario
Cese: 04/02/2020

FERNANDEZ CORTES MIGUEL ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 28/01/2020

AFIANZA ASESORES SL

Secretario no consejero
Cese: 28/01/2020

NOBLE III JAMES KENDRICK

Consejero
Cese: 28/01/2020

FURSTEIN MARC KEITH

Consejero
Cese: 28/01/2020

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Consejero
Cese: 28/01/2020

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Presidente
Cese: 28/01/2020

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Consejero delegado
Nombramiento: 28/01/2020

SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 3 SL

Administrador único
Nombramiento: 28/01/2020

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Nombramiento: 22/12/2017

BENDITO PRIETO CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/12/2017

FERNANDEZ CORTES MIGUEL ANGEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/12/2016

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Apoderado
Nombramiento: 23/12/2016

NOBLE III JAMES KENDRICK

Apoderado
Nombramiento: 23/12/2016

FURSTEIN MARC KEITH

Apoderado
Nombramiento: 23/12/2016

SILVERS SCOTT J

Apoderado
Nombramiento: 23/12/2016

BROOKE SORKIN JENNIFER

Apoderado
Nombramiento: 29/11/2016

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Consejero delegado
Cese: 15/09/2016

PANTALEON PRIETO MARCOS JESUS

Consejero
Cese: 15/09/2016

PANTALEON PRIETO MARCOS JESUS

Presidente
Cese: 15/09/2016

DIEGO ABASCAL ALFREDO

Consejero
Cese: 15/09/2016

DIEGO ABASCAL ALFREDO

Secretario
Cese: 15/09/2016

PEREZ SIERRA MANUEL

Consejero
Cese: 15/09/2016

PANTALEON PRIETO MARCOS JESUS

Consejero delegado
Cese: 15/09/2016

SANCHEZ NORIEGA JAVIER

Consejero
Cese: 15/09/2016

SALCINES BERZOSA JUAN CARLOS

Consejero
Cese: 15/09/2016

DIEGO ABASCAL ALFREDO

Apoderado
Cese: 15/09/2016

PEREZ SIERRA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 15/09/2016

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Consejero
Nombramiento: 15/09/2016

DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL

Presidente
Nombramiento: 15/09/2016

FURSTEIN MARC KEITH

Consejero
Nombramiento: 15/09/2016

NOBLE III JAME KENDRICK

Consejero
Nombramiento: 15/09/2016

AFIANZA ASESORES SL

Secretario no consejero
Nombramiento: 22/03/2010

DIEGO ABASCAL ALFREDO

Apoderado
Cese: 22/03/2010

PEREZ SIERRA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 22/03/2010

PEREZ SIERRA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 15/02/2010

SANCHEZ NORIEGA JAVIER

Consejero
Nombramiento: 15/02/2010

SALCINES BERZOSA JUAN CARLOS

Consejero

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by DEVA RENOVABLES SL

22/12/2020 Details of the advert (453899) Registry data: T 35068 , F 217, S 8, H M 630689, I/A 11 (15.12.20).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

07/02/2020 Details of the advert (58521) Registry data: T 35068 , F 216, S 8, H M 630689, I/A 10 (31.01.20).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE;GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

04/02/2020 Details of the advert (50909) Registry data: T 35068 , F 215, S 8, H M 630689, I/A 9 (28.01.20).

  • Revocaciones

    Apoderado: DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL;NOBLE III JAMES KENDRICK;FURSTEIN MARC KEITH;SILVERS SCOTT J.;BROOKE SORKIN JENNIFER. Apo.Sol.: BENDITO PRIETO CARLOS;FERNANDEZ CORTES MIGUEL ANGEL.

28/01/2020 Details of the advert (38496) Registry data: T 35068 , F 215, S 8, H M 630689, I/A 8 (21.01.20).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: AFIANZA ASESORES SL. Consejero: NOBLE III JAMES KENDRICK;FURSTEIN MARC KEITH;DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL. Presidente: DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL. Con.Delegado: DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 3 SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

  • Cambio de domicilio social

    C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 - PLANTA 12 (MADRID).

22/12/2017 Details of the advert (501555) Registry data: T 35068 , F 214, S 8, H M 630689, I/A 7 (14.12.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: BENDITO PRIETO CARLOS;FERNANDEZ CORTES MIGUEL ANGEL.

23/12/2016 Details of the advert (521782) Registry data: T 35068 , F 213, S 8, H M 630689, I/A 6 (14.12.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL;NOBLE III JAMES KENDRICK;FURSTEIN MARC KEITH;SILVERS SCOTT J.;BROOKE SORKIN JENNIFER.

29/11/2016 Details of the advert (482926) Registry data: T 35068 , F 213, S 8, H M 630689, I/A 5 (18.11.16).

  • Nombramientos

    Con.Delegado: DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL.

03/11/2016 Details of the advert (443138) Registry data: T 35068 , F 213, S 8, H M 630689, I/A 4 (24.10.16).

  • Modificaciones Estatutarias

    INCLUSION DEL ARTICULO 10.4 EN LOS ESTATUTOS SOCIALES..

31/10/2016 Details of the advert (438644) Registry data: T 35068 , F 212, S 8, H M 630689, I/A 3 (20.10.16).

  • Sociedad Unipersonal

    ERCO ASSETCO SL.

19/10/2016 Details of the advert (420588) Registry data: T 35068 , F 212, S 8, H M 630689, I/A 2 ( 5.10.16).

  • Cambio de domicilio social

    C/ ANTONIO MAURA 10 2º (MADRID).

Mercantile Registry documents related: 20

#CVE
Date
State
BORME-A-2020-244-28 22/12/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-26-28 07/02/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-23-28 04/02/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-18-28 28/01/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2017-242-28 22/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-243-28 23/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-227-28 29/11/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-210-28 03/11/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-208-28 31/10/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-200-28 19/10/2016 Madrid Descargar