DESBOR ANFER SL

Extinta

URB FLORESTA 33-B (OLIAS DEL REY).
 Olías del Rey, Toledo  (45280)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 09/03/2023

IVORRA MIRALLES FRANCISCO

Administrador único
Nombramiento: 09/03/2023

FRANCISCO IVORRA MIRALLES

Liquidador
Cese: 25/07/2013

GARCIA-OCHOA MARIN JULIAN

Administrador mancomunado
Cese: 25/07/2013

IVORRA MIRALLES FRANCISCO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 25/07/2013

IVORRA MIRALLES FRANCISCO

Administrador único
Cese: 29/06/2011

GARCIA-OCHOA MARIN JULIAN

Administrador mancomunado
Cese: 29/06/2011

IVORRA MIRALLES FRANCISCO

Administrador mancomunado
Cese: 29/06/2011

FERNANDEZ BORDES ANTONIO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 29/06/2011

IVORRA MIRALLES FRANCISCO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 29/06/2011

GARCIA-OCHOA MARIN JULIAN

Administrador mancomunado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by DESBOR ANFER SL

09/03/2023 Details of the advert (121333) Registry data: T 1751 , F 219, S 8, H TO 22681, I/A 10 ( 2.03.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: IVORRA MIRALLES FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Liquidador: FRANCISCO IVORRA MIRALLES.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

24/01/2023 Details of the advert (39255) Registry data: T 1751 , F 219, S 8, H TO 22681, I/A 9 (16.01.23).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    FRANCISCO IVORRA MIRALLES.

05/08/2013 Details of the advert (350533) Registry data: T 1290 , F 208, S 8, H TO 22681, I/A 8 (18.07.13).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 337.368,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.234.322,00 Euros.

25/07/2013 Details of the advert (335056) Registry data: T 1290 , F 208, S 8, H TO 22681, I/A 7 (18.07.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: GARCIA-OCHOA MARIN JULIAN;IVORRA MIRALLES FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: IVORRA MIRALLES FRANCISCO.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 437.934,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.896.954,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único.

02/09/2011 Details of the advert (426353)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

29/06/2011 Details of the advert (275735) Registry data: T 1290 , F 208, S 8, H TO 22681, I/A 6 (16.06.11).

  • Cambio de domicilio social

    URB FLORESTA 33-B (OLIAS DEL REY).

29/06/2011 Details of the advert (275734) Registry data: T 1290 , F 207, S 8, H TO 22681, I/A 5 (16.06.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: GARCIA-OCHOA MARIN JULIAN;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;FERNANDEZ BORDES ANTONIO.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;GARCIA-OCHOA MARIN JULIAN.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.000.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.459.020,00 Euros.

02/12/2010 Details of the advert (1123422)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2010) Año: 2009

02/12/2010 Details of the advert (1123375)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2010) Año: 2008

06/11/2009 Details of the advert (467074) Registry data: T 1290 , F 207, S 8, H TO 22681, I/A 4 (26.10.09).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 459.000,00 Euros.

Mercantile Registry documents related: 10

#CVE
Date
State
BORME-A-2023-48-45 09/03/2023 Toledo Descargar
BORME-A-2023-16-45 24/01/2023 Toledo Descargar
BORME-A-2013-147-45 05/08/2013 Toledo Descargar
BORME-A-2013-140-45 25/07/2013 Toledo Descargar
BORME-B-2011-168-45 02/09/2011 Toledo Descargar
BORME-A-2011-123-45 29/06/2011 Toledo Descargar
BORME-A-2011-123-45 29/06/2011 Toledo Descargar
BORME-B-2010-231-45 02/12/2010 Toledo Descargar
BORME-B-2010-231-45 02/12/2010 Toledo Descargar
BORME-A-2009-213-45 06/11/2009 Toledo Descargar