DAECA COMAREX SL
Cambio de denominación social
If you want to update or modify register for free
Last movements
|
Date
|
Name
|
|
|---|---|---|
| Cese: 06/10/2011 | DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO |
Consejero |
| Cese: 06/10/2011 | TORRE DE HERCULES SL |
Consejero |
| Cese: 06/10/2011 | CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL |
Consejero |
| Cese: 06/10/2011 | TORRE DE HERCULES SL |
Secretario |
| Cese: 06/10/2011 | BECEGA EXCHANGE SL |
Consejero |
| Cese: 06/10/2011 | BECEGA EXCHANGE SL |
Presidente |
| Nombramiento: 06/10/2011 | GALERAS - ENTRERIOS SL |
Administrador mancomunado |
| Nombramiento: 06/10/2011 | GPS DEL NOROESTE 3000 SL |
Administrador mancomunado |
| Cese: 23/11/2009 | RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 23/11/2009 | DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 23/11/2009 | DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 23/11/2009 | ROSADO BADILLO RAFAEL |
Apoderado solidario |
| Cese: 23/11/2009 | RODRIGUEZ-ACOSTA FERNANDEZ-FIGARES GUSTAVO |
Apoderado solidario |
| Cese: 23/11/2009 | BARCOS JIMENEZ JUAN |
Apoderado |
| Cese: 22/10/2009 | CANO RUIZ JAIME |
Secretario |
| Cese: 22/10/2009 | RODRIGUEZ-ACOSTA FERNANDEZ-FIGARES GUSTAVO |
Consejero |
| Cese: 22/10/2009 | RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE |
Presidente |
| Cese: 22/10/2009 | RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 22/10/2009 | CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL |
Consejero |
| Nombramiento: 22/10/2009 | TORRE DE HERCULES SL |
Consejero |
| Cese: 22/10/2009 | C POR G DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL |
Presidente |
| Cese: 22/10/2009 | C POR G DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL |
Consejero |
| Nombramiento: 22/10/2009 | BECEGA EXCHANGE SL |
Consejero |
| Nombramiento: 22/10/2009 | BECEGA EXCHANGE SL |
Presidente |
| Nombramiento: 22/10/2009 | C POR G DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL |
Presidente |
| Nombramiento: 22/10/2009 | TORRE DE HERCULES SL |
Secretario |
| Nombramiento: 22/10/2009 | DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 22/10/2009 | DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO |
Apoderado mancomunado |
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by DAECA COMAREX SL
22/11/2011 Details of the advert (464634) Registry data: T 3369 , F 114, S 8, H C 45626, I/A 7 (14.11.11).
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: 1º. Denominación.-.
- Cambio de denominación social
TORRES DEL BOULEVAR SL.
08/11/2011 Details of the advert (919042)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2011)
06/10/2011 Details of the advert (398346) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 6 (28.09.11).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO;TORRE DE HERCULES SL;CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Secretario: TORRE DE HERCULES SL. Consejero: BECEGA EXCHANGE SL. Presidente: BECEGA EXCHANGE SL.
- Nombramientos
Adm. Mancom.: GALERAS - ENTRERIOS SL;GPS DEL NOROESTE 3000 SL.
- Modificaciones Estatutarias
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados.
23/09/2010 Details of the advert (360337) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 5 (14.09.10).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 9.505.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.300,00 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: RELATIVOAL CAPITAL SOCIAL Y AL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.-.
30/08/2010 Details of the advert (406356)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2010)
23/11/2009 Details of the advert (488134) Registry data: T 3369 , F 112, S 8, H C 45626, I/A 2 (12.11.09).
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio..
- Cambio de domicilio social
AVDA LINARES RIVAS 30 3º (CORUÑA (A)).
23/11/2009 Details of the advert (488135) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 3 (12.11.09).
- Revocaciones
Apo.Manc.: RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE;DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO;DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: ROSADO BADILLO RAFAEL;RODRIGUEZ-ACOSTA FERNANDEZ-FIGARES GUSTAVO. Apoderado: BARCOS JIMENEZ JUAN.
23/11/2009 Details of the advert (488136) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 4 (12.11.09).
- Modificaciones Estatutarias
Relativo a la Junta General..
19/11/2009 Details of the advert (887373)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2009) Año: 2006
19/11/2009 Details of the advert (893154)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2009) Año: 2008
Mercantile Registry documents related: 16
|
#CVE
|
Date
|
State
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2011-221-15 | 22/11/2011 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2011-212-15 | 08/11/2011 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2011-191-15 | 06/10/2011 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2010-184-15 | 23/09/2010 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2010-166-15 | 30/08/2010 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2009-223-15 | 23/11/2009 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2009-223-15 | 23/11/2009 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-A-2009-223-15 | 23/11/2009 | Coruña, A | Descargar |
| BORME-B-2009-221-18 | 19/11/2009 | Granada | Descargar |
| BORME-B-2009-221-18 | 19/11/2009 | Granada | Descargar |