DAECA COMAREX SL

Cambio de denominación social

AVDA LINARES RIVAS 30 3º (CORUÑA (A)).
Coruña, A
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 06/10/2011

DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO

Consejero
Cese: 06/10/2011

TORRE DE HERCULES SL

Consejero
Cese: 06/10/2011

CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL

Consejero
Cese: 06/10/2011

TORRE DE HERCULES SL

Secretario
Cese: 06/10/2011

BECEGA EXCHANGE SL

Consejero
Cese: 06/10/2011

BECEGA EXCHANGE SL

Presidente
Nombramiento: 06/10/2011

GALERAS - ENTRERIOS SL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 06/10/2011

GPS DEL NOROESTE 3000 SL

Administrador mancomunado
Cese: 23/11/2009

RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE

Apoderado mancomunado
Cese: 23/11/2009

DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO

Apoderado mancomunado
Cese: 23/11/2009

DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER

Apoderado mancomunado
Cese: 23/11/2009

ROSADO BADILLO RAFAEL

Apoderado solidario
Cese: 23/11/2009

RODRIGUEZ-ACOSTA FERNANDEZ-FIGARES GUSTAVO

Apoderado solidario
Cese: 23/11/2009

BARCOS JIMENEZ JUAN

Apoderado
Cese: 22/10/2009

CANO RUIZ JAIME

Secretario
Cese: 22/10/2009

RODRIGUEZ-ACOSTA FERNANDEZ-FIGARES GUSTAVO

Consejero
Cese: 22/10/2009

RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE

Presidente
Cese: 22/10/2009

RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE

Consejero
Nombramiento: 22/10/2009

CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL

Consejero
Nombramiento: 22/10/2009

TORRE DE HERCULES SL

Consejero
Cese: 22/10/2009

C POR G DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL

Presidente
Cese: 22/10/2009

C POR G DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL

Consejero
Nombramiento: 22/10/2009

BECEGA EXCHANGE SL

Consejero
Nombramiento: 22/10/2009

BECEGA EXCHANGE SL

Presidente
Nombramiento: 22/10/2009

C POR G DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL

Presidente
Nombramiento: 22/10/2009

TORRE DE HERCULES SL

Secretario
Nombramiento: 22/10/2009

DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 22/10/2009

DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO

Apoderado mancomunado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by DAECA COMAREX SL

22/11/2011 Details of the advert (464634) Registry data: T 3369 , F 114, S 8, H C 45626, I/A 7 (14.11.11).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 1º. Denominación.-.

  • Cambio de denominación social

    TORRES DEL BOULEVAR SL.

08/11/2011 Details of the advert (919042)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2011)

06/10/2011 Details of the advert (398346) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 6 (28.09.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO;TORRE DE HERCULES SL;CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Secretario: TORRE DE HERCULES SL. Consejero: BECEGA EXCHANGE SL. Presidente: BECEGA EXCHANGE SL.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: GALERAS - ENTRERIOS SL;GPS DEL NOROESTE 3000 SL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados.

23/09/2010 Details of the advert (360337) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 5 (14.09.10).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 9.505.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.300,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: RELATIVOAL CAPITAL SOCIAL Y AL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.-.

30/08/2010 Details of the advert (406356)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010)

23/11/2009 Details of the advert (488134) Registry data: T 3369 , F 112, S 8, H C 45626, I/A 2 (12.11.09).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio..

  • Cambio de domicilio social

    AVDA LINARES RIVAS 30 3º (CORUÑA (A)).

23/11/2009 Details of the advert (488135) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 3 (12.11.09).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL JOSE;DIEZ DE LEON FERNANDEZ ALBERTO SANTIAGO;DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: ROSADO BADILLO RAFAEL;RODRIGUEZ-ACOSTA FERNANDEZ-FIGARES GUSTAVO. Apoderado: BARCOS JIMENEZ JUAN.

23/11/2009 Details of the advert (488136) Registry data: T 3369 , F 113, S 8, H C 45626, I/A 4 (12.11.09).

  • Modificaciones Estatutarias

    Relativo a la Junta General..

19/11/2009 Details of the advert (887373)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2009) Año: 2006

19/11/2009 Details of the advert (893154)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 16

#CVE
Date
State
BORME-A-2011-221-15 22/11/2011 Coruña, A Descargar
BORME-B-2011-212-15 08/11/2011 Coruña, A Descargar
BORME-A-2011-191-15 06/10/2011 Coruña, A Descargar
BORME-A-2010-184-15 23/09/2010 Coruña, A Descargar
BORME-B-2010-166-15 30/08/2010 Coruña, A Descargar
BORME-A-2009-223-15 23/11/2009 Coruña, A Descargar
BORME-A-2009-223-15 23/11/2009 Coruña, A Descargar
BORME-A-2009-223-15 23/11/2009 Coruña, A Descargar
BORME-B-2009-221-18 19/11/2009 Granada Descargar
BORME-B-2009-221-18 19/11/2009 Granada Descargar