CORETHERAPIX SL

Extinta

C/ MARCONI 1 - PARQUE TECNOLOGICO DE MADRID (TRES CANTOS).
 Tres Cantos, Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 16/06/2023

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Administrador único
Cese: 16/06/2023

LAPEÑA BOTIJA MARIA LOURDES

Apoderado
Cese: 16/06/2023

DAUGUSTA CLAUDIA

Apoderado
Cese: 16/06/2023

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Apoderado
Cese: 16/06/2023

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Apoderado
Cese: 16/06/2023

PASTOR CABALLERO CECILIA

Apoderado solidario
Cese: 16/06/2023

TERAN MUÑOZ SANTIAGO

Apoderado solidario
Cese: 16/06/2023

VAZQUEZ LOPEZ EUGENIA

Apoderado solidario
Cese: 16/06/2023

ARIAS BERNARDO MARIA

Apoderado solidario
Cese: 16/06/2023

TRELLO CORRALES ANA

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/06/2023

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Liquidador
Cese: 18/02/2022

WEHLE SEBASTIAN

Administrador único
Nombramiento: 18/02/2022

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Administrador único
Nombramiento: 18/01/2021

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Apoderado
Nombramiento: 18/01/2021

PASTOR CABALLERO CECILIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/01/2021

TERAN MUÑOZ SANTIAGO

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/01/2021

VAZQUEZ LOPEZ EUGENIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/01/2021

ARIAS BERNARDO MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/01/2021

TRELLO CORRALES ANA

Apoderado solidario
Nombramiento: 08/11/2018

REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR

Apoderado
Cese: 07/11/2018

BRAVO FERNANDEZ DE ARAOZ EDUARDO

Administrador único
Nombramiento: 07/11/2018

WEHLE SEBASTIAN

Administrador único
Nombramiento: 08/10/2015

DAUGUSTA CLAUDIA

Apoderado
Cese: 08/10/2015

GENETRIX SL

Administrador único
Cese: 08/10/2015

DEL CASTILLO TAMAYO JUAN CARLOS

Representante
Nombramiento: 08/10/2015

BRAVO FERNANDEZ DE ARAOZ EDUARDO

Administrador único
Cese: 30/01/2015

LAPEÑA BOTIJA MARIA LOURDES

Apoderado mancomunado
Cese: 30/01/2015

GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO

Apoderado mancomunado
Cese: 30/01/2015

GOMEZ- ALMANSA PLAZA ANTONIO

Apoderado
Cese: 13/05/2013

DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR

Representante
Nombramiento: 13/05/2013

DEL CASTILLO TAMAYO JUAN CARLOS

Representante
Cese: 28/10/2011

MULET PARADA MIGUEL

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by CORETHERAPIX SL

16/06/2023 Details of the advert (274353) Registry data: T 33076 , F 64, S 8, H M 443970, I/A 30 ( 9.06.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR.

  • Revocaciones

    Apoderado: LAPEÑA BOTIJA MARIA LOURDES;DAUGUSTA CLAUDIA;REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR;REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: PASTOR CABALLERO CECILIA;TERAN MUÑOZ SANTIAGO;VAZQUEZ LOPEZ EUGENIA;ARIAS BERNARDO MARIA;TRELLO CORRALES ANA.

  • Nombramientos

    Liquidador: REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

18/02/2022 Details of the advert (75018) Registry data: T 33076 , F 64, S 8, H M 443970, I/A 29 (11.02.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: WEHLE SEBASTIAN.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR.

18/01/2021 Details of the advert (19990) Registry data: T 33076 , F 63, S 8, H M 443970, I/A 28 (11.01.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: PASTOR CABALLERO CECILIA;TERAN MUÑOZ SANTIAGO;VAZQUEZ LOPEZ EUGENIA;ARIAS BERNARDO MARIA;TRELLO CORRALES ANA.

25/06/2019 Details of the advert (275481) Registry data: T 33076 , F 63, S 8, H M 443970, I/A 27 (18.06.19).

  • Sociedad Unipersonal

    TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG.

08/11/2018 Details of the advert (447598) Registry data: T 33076 , F 62, S 8, H M 443970, I/A 25 (31.10.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: REDONDO PASTOR MARIA DEL PILAR.

07/11/2018 Details of the advert (444939) Registry data: T 33076 , F 62, S 8, H M 443970, I/A 24 (29.10.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: BRAVO FERNANDEZ DE ARAOZ EDUARDO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: WEHLE SEBASTIAN.

11/11/2015 Details of the advert (453930) Registry data: T 33076 , F 62, S 8, H M 443970, I/A 23 ( 2.11.15).

  • Cambio de domicilio social

    C/ MARCONI 1 - PARQUE TECNOLOGICO DE MADRID (TRES CANTOS).

08/10/2015 Details of the advert (404901) Registry data: T 33076 , F 60, S 8, H M 443970, I/A 21 (28.09.15).

  • Sociedad Unipersonal

    TIGENIX NV.

08/10/2015 Details of the advert (404902) Registry data: T 33076 , F 60, S 8, H M 443970, I/A 22 (28.09.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: DAUGUSTA CLAUDIA.

08/10/2015 Details of the advert (404900) Registry data: T 33076 , F 60, S 8, H M 443970, I/A 20 (28.09.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GENETRIX SL. Representan: DEL CASTILLO TAMAYO JUAN CARLOS.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: BRAVO FERNANDEZ DE ARAOZ EDUARDO.

Mercantile Registry documents related: 22

#CVE
Date
State
BORME-A-2023-113-28 16/06/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-34-28 18/02/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-10-28 18/01/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2019-119-28 25/06/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-215-28 08/11/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-214-28 07/11/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2015-215-28 11/11/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-193-28 08/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-193-28 08/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-193-28 08/10/2015 Madrid Descargar