CONSTRUCCIONES BECERVI SL

Cierre provisional

C/ BAIX DEL CARME 51 (REUS).
 Reus, Tarragona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 06/08/2018

GIRONA CRUSAT JAUME

Administrador único
Nombramiento: 06/08/2018

PORUMBEL TUDOR

Administrador único
Cese: 06/10/2015

MILLAN RALDA ELISEO JOSE

Administrador único
Nombramiento: 06/10/2015

GIRONA CRUSAT JAUME

Administrador único
Cese: 16/09/2015

QUEROL EDO MANUEL

Administrador solidario
Cese: 16/09/2015

ROMEU CELSO RAFAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 16/09/2015

MILLAN RALDA ELISEO JOSE

Administrador único
Cese: 30/06/2015

SUÑER SAN LORENZO EDUARDO MANUEL

Consejero
Cese: 30/06/2015

ROMEU CELSO RAFAEL

Consejero
Cese: 30/06/2015

QUEROL EDO MANUEL

Consejero
Cese: 30/06/2015

SUÑER SAN LORENZO EDUARDO MANUEL

Presidente
Cese: 30/06/2015

SUÑER SAN LORENZO EDUARDO MANUEL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 30/06/2015

ROMEU CELSO RAFAEL

Secretario
Cese: 30/06/2015

ROMEU CELSO RAFAEL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 30/06/2015

QUEROL EDO MANUEL

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 30/06/2015

ROMEU CELSO RAFAEL

Administrador solidario
Nombramiento: 30/06/2015

QUEROL EDO MANUEL

Administrador solidario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by CONSTRUCCIONES BECERVI SL

12/07/2021 Details of the advert (335397) Registry data: T 2907 , F 31, S 8, H T 48962, I/A BAJA (31.05.21).

  • Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas

27/05/2021 Details of the advert (256436) Registry data: T 2907 , F 31, S 8, H T 48962, I/ARVCIF (11.05.21).

  • Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF

06/08/2018 Details of the advert (326276) Registry data: T 2907 , F 37, S 8, H T 48962, I/A 3 (30.07.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GIRONA CRUSAT JAUME.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: PORUMBEL TUDOR.

10/11/2015 Details of the advert (452038) Registry data: T 2907 , F 37, S 8, H T 48962, I/A 2 ( 2.11.15).

  • Cambio de domicilio social

    C/ BAIX DEL CARME 51 (REUS).

06/10/2015 Details of the advert (401068) Registry data: T 596, L 163, F 111, S 8, H CS 4439, I/A 8 (30.09.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: MILLAN RALDA ELISEO JOSE.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GIRONA CRUSAT JAUME.

16/09/2015 Details of the advert (377104) Registry data: T 596, L 163, F 111, S 8, H CS 4439, I/A 7 (10.09.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: QUEROL EDO MANUEL;ROMEU CELSO RAFAEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: MILLAN RALDA ELISEO JOSE.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.

30/06/2015 Details of the advert (267649) Registry data: T 596, L 163, F 110, S 8, H CS 4439, I/A 6 (19.06.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: SUÑER SAN LORENZO EDUARDO MANUEL;ROMEU CELSO RAFAEL;QUEROL EDO MANUEL. Presidente: SUÑER SAN LORENZO EDUARDO MANUEL. Cons.Del.Man: SUÑER SAN LORENZO EDUARDO MANUEL. Secretario: ROMEU CELSO RAFAEL. Cons.Del.Man: ROMEU CELSO RAFAEL;QUEROL EDO MANUEL.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: ROMEU CELSO RAFAEL;QUEROL EDO MANUEL.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 4.146,90 Euros. Resultante Suscrito: 3.065,10 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: MODIFICADO por reducción de capital.. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.

  • Escisión Parcial

    Sociedades beneficiarias de la escisión: PLAYMAR INNOVACION 2014 SL. SANLORENZO PROYECTOS Y GESTION SL.

02/01/2015 Details of the advert (1)

  • Depósitos de proyectos de escisión parcial

23/09/2011 Details of the advert (587476)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

19/10/2010 Details of the advert (850650)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

Mercantile Registry documents related: 12

#CVE
Date
State
BORME-A-2021-131-43 12/07/2021 Tarragona Descargar
BORME-A-2021-99-43 27/05/2021 Tarragona Descargar
BORME-A-2018-150-43 06/08/2018 Tarragona Descargar
BORME-A-2015-214-43 10/11/2015 Tarragona Descargar
BORME-A-2015-191-12 06/10/2015 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2015-177-12 16/09/2015 Castellón/Castelló Descargar
BORME-A-2015-121-12 30/06/2015 Castellón/Castelló Descargar
BORME-B-2015-1-12 02/01/2015 Castellón/Castelló Descargar
BORME-B-2011-182-12 23/09/2011 Castellón/Castelló Descargar
BORME-B-2010-201-12 19/10/2010 Castellón/Castelló Descargar