CLINSA SA

Activa

CALLE ARTURO SORIA, 103
Madrid  (28043)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 30/10/2024

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 23/08/2024

RICO PEREZ PEDRO

Administrador solidario
Cese: 21/12/2023

TABERNERO ALBA EDUARDO

Apoderado
Nombramiento: 14/11/2023

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 26/09/2023

LORENTE GONZALEZ ALFONSO

Apoderado
Cese: 26/09/2023

GARCIA FERNANDEZ CRISTINA

Apoderado
Cese: 24/02/2023

CABRERIZO EXTREMERA ABEL

Apoderado
Nombramiento: 03/02/2023

ONCINS FANNING MARIA DEL PILAR

Apoderado
Cese: 17/11/2022

MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA

Apoderado solidario
Nombramiento: 14/10/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by CLINSA SA

30/10/2024 Details of the advert (464226) Registry data: S 8 , H M 87972, I/A 109 (23.10.24).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

23/08/2024 Details of the advert (370312) Registry data: S 8 , H M 87972, I/A 108 (17.08.24).

  • Reelecciones

    Adm. Solid.: RICO PEREZ PEDRO.

21/12/2023 Details of the advert (543556) Registry data: T 44808 , F 4, S 8, H M 87972, I/A 107 (14.12.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: TABERNERO ALBA EDUARDO.

14/11/2023 Details of the advert (481770) Registry data: T 44808 , F 4, S 8, H M 87972, I/A 106 ( 6.11.23).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

26/09/2023 Details of the advert (414582) Registry data: T 44808 , F 2, S 8, H M 87972, I/A 104 (19.09.23).

  • Nombramientos

    Apoderado: LORENTE GONZALEZ ALFONSO.

26/09/2023 Details of the advert (414583) Registry data: T 44808 , F 4, S 8, H M 87972, I/A 105 (19.09.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: GARCIA FERNANDEZ CRISTINA.

03/03/2023 Details of the advert (111425) Registry data: T 42263 , F 219, S 8, H M 87972, I/A 102 (24.02.23).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 26.131,48 Euros. Resultante Suscrito: 6.994.245,68 Euros.

03/03/2023 Details of the advert (111426) Registry data: T 44808 , F 2, S 8, H M 87972, I/A 103 (24.02.23).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    VITHAS SANIDAD SL.

24/02/2023 Details of the advert (99612) Registry data: T 42263 , F 219, S 8, H M 87972, I/A 101 (17.02.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: CABRERIZO EXTREMERA ABEL.

03/02/2023 Details of the advert (60880) Registry data: T 42263 , F 218, S 8, H M 87972, I/A 100 (27.01.23).

  • Nombramientos

    Apoderado: ONCINS FANNING MARIA DEL PILAR.

Mercantile Registry documents related: 43

#CVE
Date
State
BORME-A-2024-210-28 30/10/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2024-162-28 23/08/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2023-241-28 21/12/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-216-28 14/11/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-184-28 26/09/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-184-28 26/09/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-44-28 03/03/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-44-28 03/03/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-39-28 24/02/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-24-28 03/02/2023 Madrid Descargar