CARMONIVEST ANDINA SL

Extinta

PS DE GRACIA Num.122 P.3 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 16/01/2018

LAGARES PUIG FRANCESC XAVIER

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 16/01/2018

TRALLERO VILAR ANTONI

Auditor de cuentas consolidadas suplente
Cese: 12/01/2018

ROBERTO GUSTAVO CARMONA

Consejero
Cese: 12/01/2018

JOSE LUIS CARMONA

Consejero
Cese: 12/01/2018

RAFOLS VIVES ROSER

Consejero
Cese: 12/01/2018

ROBERTO GUSTAVO CARMONA

Vicepresidente
Cese: 12/01/2018

RAFOLS VIVES ROSER

Liquidador
Cese: 12/01/2018

RAFOLS VIVES ROSER

Secretario
Cese: 12/01/2018

JOSE LUIS CARMONA

Presidente
Nombramiento: 12/01/2018

RAFOLS VIVES ROSER

Liquidador
Nombramiento: 12/01/2018

RAFOLS VIVES ROSER

Consejero
Nombramiento: 12/01/2018

ROBERTO GUSTAVO CARMONA

Vicepresidente
Nombramiento: 12/01/2018

RAFOLS VIVES ROSER

Secretario
Nombramiento: 12/01/2018

JOSE LUIS CARMONA

Presidente
Cese: 11/12/2015

ALICIA DEL ROSARIO CARMONA

Consejero
Cese: 11/12/2015

CARMONA CORTES PATRICIA INES

Consejero
Cese: 11/12/2015

GERMAN CAPARROZ

Consejero
Cese: 11/12/2015

LLEVAT FELIUS ALEJANDRO

Secretario no consejero
Cese: 11/12/2015

ALICIA DEL ROSARIO CARMONA

Presidente
Cese: 11/12/2015

SANTANA NAVARRO EDUARDO

Consejero
Cese: 20/02/2013

ROBERT JEAN MICHEL BOTTE

Consejero
Nombramiento: 20/02/2013

SANTANA NAVARRO EDUARDO

Consejero
Nombramiento: 30/11/2012

GASSO AUDITORES SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 15/09/2010

ALICIA DEL ROSARIO CARMONA

Apoderado
Cese: 15/09/2010

CARMONA CORTES PATRICIA INES

Apoderado
Cese: 15/09/2010

ROBERTO GUSTAVO CARMONA

Apoderado
Cese: 15/09/2010

JOSE LUIS CARMONA

Apoderado
Nombramiento: 15/09/2010

ALICIA DEL ROSARIO CARMONA

Apoderado
Nombramiento: 15/09/2010

PATRICIA INES CARMONA CORTES

Apoderado
Nombramiento: 15/09/2010

ROBERTO GUSTAVO CARMONA

Apoderado
Nombramiento: 15/09/2010

GERMAN CAPARROZ

Apoderado
Nombramiento: 15/09/2010

JOSE LUIS CARMONA

Apoderado
Cese: 12/08/2010

CARMONA CORTES PATRICIA INES

Presidente
Nombramiento: 12/08/2010

ALICIA DEL ROSARIO CARMONA

Presidente
Cese: 19/05/2010

ZURITA SAENZ DE NAVARRETE MIGUEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 17/05/2010

ZURITA SAENZ DE NAVARRETE MIGUEL

Consejero
Cese: 17/05/2010

MILLAN CRUZ MARIA DEL CARMEN

Secretario
Cese: 17/05/2010

MOLINA LOPEZ MARIA DE LOS MILAGROS

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 17/05/2010

CAPARROZ GERMAN

Consejero
Nombramiento: 17/05/2010

LLEVAT FELIUS ALEJANDRO

Secretario

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by CARMONIVEST ANDINA SL

16/01/2018 Details of the advert (20489) Registry data: T 42009 , F 22, S 8, H B 398887, I/A 20 ( 4.01.18).

  • Nombramientos

    AUDT.CTS.CON: LAGARES PUIG FRANCESC XAVIER. AUDIT.CC.SUP: TRALLERO VILAR ANTONI.

12/01/2018 Details of the advert (16683) Registry data: T 42009 , F 22, S 8, H B 398887, I/A 21 ( 4.01.18).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: ROBERTO GUSTAVO CARMONA;JOSE LUIS CARMONA;RAFOLS VIVES ROSER. VICEPRESIDEN: ROBERTO GUSTAVO CARMONA. LIQUIDADOR: RAFOLS VIVES ROSER. SECRETARIO: RAFOLS VIVES ROSER. PRESIDENTE: JOSE LUIS CARMONA.

  • Nombramientos

    LIQUIDADOR: RAFOLS VIVES ROSER.

  • Extinción

12/01/2018 Details of the advert (16679) Registry data: T 42009 , F 22, S 8, H B 398887, I/A 19 ( 4.01.18).

  • Nombramientos

    CONSEJERO: RAFOLS VIVES ROSER. VICEPRESIDEN: ROBERTO GUSTAVO CARMONA. SECRETARIO: RAFOLS VIVES ROSER. PRESIDENTE: JOSE LUIS CARMONA.

  • Cambio de domicilio social

    PS DE GRACIA Num.122 P.3 (BARCELONA).

11/12/2015 Details of the advert (501599) Registry data: T 42009 , F 21, S 8, H B 398887, I/A 18 (27.11.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: ALICIA DEL ROSARIO CARMONA;CARMONA CORTES PATRICIA INES;GERMAN CAPARROZ. SECR.NO CONS: LLEVAT FELIUS ALEJANDRO. PRESIDENTE: ALICIA DEL ROSARIO CARMONA. CONSEJERO: SANTANA NAVARRO EDUARDO.

07/10/2013 Details of the advert (428007) Registry data: T 42009 , F 21, S 8, H B 398887, I/A 17 (26.09.13).

  • Modificaciones Estatutarias

    ART.10:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.

20/02/2013 Details of the advert (84006) Registry data: T 42009 , F 21, S 8, H B 398887, I/A 16 (12.02.13).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: ROBERT JEAN MICHEL BOTTE.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: SANTANA NAVARRO EDUARDO.

30/11/2012 Details of the advert (494047) Registry data: T 42009 , F 20, S 8, H B 398887, I/A 15 (20.11.12).

  • Nombramientos

    AUDT.CTS.CON: GASSO AUDITORES SLP.

08/11/2011 Details of the advert (900305)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

08/11/2011 Details of the advert (895575)

  • Cuentas consolidadas

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

20/01/2011 Details of the advert (33211)

  • Cuentas consolidadas

    (Diciembre de 2010) Año: 2009

Mercantile Registry documents related: 19

#CVE
Date
State
BORME-A-2018-11-08 16/01/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-9-08 12/01/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-9-08 12/01/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-236-08 11/12/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-191-08 07/10/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-35-08 20/02/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-230-08 30/11/2012 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-212-08 08/11/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-212-08 08/11/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-13-08 20/01/2011 Barcelona Descargar