CABLERIAS CONDUCTORAS SL

Cambio de denominación social

POLIG INDUSTRIAL AS GANDARAS S/N - PARCELA 204 (PORRIÑO (O)).
 PORRIÑO O, Pontevedra
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 25/05/2018

GONZALEZ SIEIRO MARCOS

Apoderado
Cese: 15/12/2014

VARELA BORREGUERO FERNANDO

Secretario no consejero
Cese: 15/12/2014

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Consejero
Cese: 15/12/2014

MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE

Consejero
Cese: 15/12/2014

GARCIA GONZALEZ JORGE

Consejero
Cese: 15/12/2014

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Consejero delegado
Cese: 15/12/2014

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Presidente
Nombramiento: 15/12/2014

MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE

Administrador solidario
Nombramiento: 15/12/2014

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Administrador solidario
Nombramiento: 23/11/2010

KPMG AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 12/05/2010

SOMOZA ALONSO MARIA JOSE

Apoderado
Nombramiento: 12/05/2010

GONZALEZ SIEIRO MARCOS

Apoderado
Nombramiento: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Consejero
Nombramiento: 25/03/2010

MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 25/03/2010

GARCIA GONZALEZ JORGE

Consejero
Nombramiento: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Consejero delegado
Nombramiento: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Presidente
Nombramiento: 25/03/2010

VARELA BORREGUERO FERNANDO

Secretario no consejero
Cese: 25/03/2010

VARELA BORREGUERO FERNANDO

Secretario
Cese: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Consejero
Cese: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Presidente
Cese: 25/03/2010

GARCIA GONZALEZ JORGE

Consejero
Cese: 25/03/2010

MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE

Consejero
Cese: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Consejero delegado
Cese: 25/03/2010

FOREST HENRI

Consejero
Cese: 25/03/2010

FICHEPAIN JEAN PIERRE

Consejero
Cese: 25/03/2010

CAMPINS TRASPUESTO BARTOLOME

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/03/2010

ALONSO MACIAS ALBERTO DANIEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/03/2010

BARBERA GOMEZ AGUSTIN

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/03/2010

MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE

Apoderado solidario
Cese: 25/03/2010

RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO

Apoderado solidario
Cese: 25/03/2010

CAMIÑA PIÑEIRO EUGENIO

Apoderado solidario
Cese: 25/03/2010

VALEIRAS SUAREZ RICARDO

Apoderado
Cese: 25/03/2010

VALEIRAS SUAREZ RICARDO

Apoderado mancomunado
Cese: 25/03/2010

ARROYO RUBIO RICARDO

Apoderado mancomunado
Cese: 25/03/2010

GONZALEZ SIEIRO MARCOS

Apoderado mancomunado
Cese: 25/03/2010

SOMOZA ALONSO MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 25/03/2010

GONZALEZ SIEIRO MARCOS

Apoderado
Cese: 25/03/2010

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA INES

Apoderado
Nombramiento: 30/10/2009

KPMG AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 04/06/2009

SOMOZA ALONSO MARIA JOSE

Apoderado
Nombramiento: 04/06/2009

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA INES

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by CABLERIAS CONDUCTORAS SL

10/07/2020 Details of the advert (218106) Registry data: T 3612, L 3612, F 36, S 8, H PO 49206, I/A 9 ( 1.07.20).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 401.382,29 Euros. Resultante Suscrito: 459.097,16 Euros.

  • Cambio de denominación social

    CABLERIAS GROUP SL.

25/05/2018 Details of the advert (222574) Registry data: T 3612, L 3612, F 35, S 8, H PO 49206, I/A 8 (15.05.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: GONZALEZ SIEIRO MARCOS.

15/12/2014 Details of the advert (509971) Registry data: T 3612, L 3612, F 35, S 8, H PO 49206, I/A 7 ( 5.12.14).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: VARELA BORREGUERO FERNANDO. Consejero: RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO;MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE;GARCIA GONZALEZ JORGE. Con.Delegado: RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO. Presidente: RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE;RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.

15/01/2014 Details of the advert (16081) Registry data: T 3612, L 3612, F 34, S 8, H PO 49206, I/A 6 ( 7.01.14).

  • Pérdida del carácter de unipersonalidad

    Ampliaciondecapital.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 2.885,75 Euros. Resultante Suscrito: 57.714,87 Euros.

25/04/2013 Details of the advert (195595) Registry data: T 3612, L 3612, F 34, S 8, H PO 49206, I/A 5 (17.04.13).

  • Modificaciones Estatutarias

    Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.

23/11/2010 Details of the advert (432961) Registry data: T 3612, L 3612, F 34, S 8, H PO 49206, I/A 4 (10.11.10).

  • Nombramientos

    Auditor: KPMG AUDITORES SL.

12/05/2010 Details of the advert (190916) Registry data: T 3612, L 3612, F 33, S 8, H PO 49206, I/A 3 (30.04.10).

  • Nombramientos

    Apoderado: SOMOZA ALONSO MARIA JOSE.

12/05/2010 Details of the advert (190917) Registry data: T 3612, L 3612, F 32, S 8, H PO 49206, I/A 2 (30.04.10).

  • Nombramientos

    Apoderado: GONZALEZ SIEIRO MARCOS.

23/04/2010 Details of the advert (167750)

  • Cuentas consolidadas

    (Abril de 2010) Año: 2008

23/04/2010 Details of the advert (167779)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Abril de 2010) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 16

#CVE
Date
State
BORME-A-2020-132-36 10/07/2020 Pontevedra Descargar
BORME-A-2018-99-36 25/05/2018 Pontevedra Descargar
BORME-A-2014-238-36 15/12/2014 Pontevedra Descargar
BORME-A-2014-9-36 15/01/2014 Pontevedra Descargar
BORME-A-2013-78-36 25/04/2013 Pontevedra Descargar
BORME-A-2010-224-36 23/11/2010 Pontevedra Descargar
BORME-A-2010-89-36 12/05/2010 Pontevedra Descargar
BORME-A-2010-89-36 12/05/2010 Pontevedra Descargar
BORME-B-2010-76-36 23/04/2010 Pontevedra Descargar
BORME-B-2010-76-36 23/04/2010 Pontevedra Descargar