AMPER SOLUCIONES SA

Extinta

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 28/07/2011

REDONDO IGLESIAS ALFREDO

Representante
Cese: 28/07/2011

CARMONA SCHMOLLING JUAN CARLOS

Representante
Cese: 28/07/2011

AMPER SA

Administrador mancomunado
Cese: 28/07/2011

SOCIEDAD ANONIMA DE FINANZAS Y TELECOMUNICACION

Administrador mancomunado
Cese: 18/02/2011

GIL AGUDO JUAN CARLOS

Apoderado
Cese: 18/02/2011

MARQUEZ DORSCH MANUEL

Apoderado
Cese: 18/02/2011

PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR

Apoderado
Cese: 18/02/2011

VALLEJO LLOPIS ANA

Apoderado
Cese: 18/02/2011

BURGOS LIZALDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 18/02/2011

MONREAL VELEZ ELIAS JOSE

Apoderado
Nombramiento: 18/02/2011

MARTINEZ MOSQUERA ANTONIO MANUEL

Apoderado
Cese: 25/11/2010

GIL AGUDO JUAN CARLOS

Representante
Nombramiento: 25/11/2010

CARMONA SCHMOLLING JUAN CARLOS

Representante
Nombramiento: 18/11/2010

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 18/11/2010

MARQUEZ DORSCH MANUEL

Representante
Nombramiento: 18/11/2010

REDONDO IGLESIAS ALFREDO

Representante
Cese: 27/04/2010

ADANERO PALOMO JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 27/04/2010

VALLEJO LLOPIS ANA

Apoderado
Cese: 14/12/2009

YLLERA FERNANDEZ RAFAEL

Apoderado
Cese: 14/12/2009

YLLERA FERNANDEZ RAFAEL

Apoderado
Nombramiento: 14/12/2009

MOYA JIMENEZ ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 14/12/2009

JAMOEL FEMKE ANNEMARIE

Apoderado
Nombramiento: 04/09/2009

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 26/06/2009

USED AZNAR ENRIQUE

Apoderado
Nombramiento: 26/06/2009

MARTOS MARTINEZ JOSE FRANCISCO

Apoderado
Cese: 03/04/2009

GIL AGUDO JUAN CARLOS

Consejero
Cese: 03/04/2009

MARQUEZ DORSCH MANUEL

Consejero
Cese: 03/04/2009

MARTOS MARTINEZ JOSE FRANCISCO

Secretario no consejero
Nombramiento: 03/04/2009

MARQUEZ DORSCH MANUEL

Representante
Nombramiento: 03/04/2009

GIL AGUDO JUAN CARLOS

Representante
Nombramiento: 03/04/2009

AMPER SA

Administrador mancomunado
Nombramiento: 03/04/2009

SOCIEDAD ANONIMA DE FINANZAS Y TELECOMUNICACION

Administrador mancomunado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by AMPER SOLUCIONES SA

28/07/2011 Details of the advert (313921) Registry data: T 15103 , F 221, S 8, H M 25881, I/A 261 (18.07.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: REDONDO IGLESIAS ALFREDO;CARMONA SCHMOLLING JUAN CARLOS. Adm. Mancom.: AMPER SA;SOCIEDAD ANONIMA DE FINANZAS Y TELECOMUNICACION.

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

13/04/2011 Details of the advert (165846) Registry data: T 15103 , F 220, S 8, H M 25881, I/A 260 ( 1.04.11).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    AMPER SA.

18/02/2011 Details of the advert (75435) Registry data: T 15103 , F 219, S 8, H M 25881, I/A 259 ( 9.02.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: GIL AGUDO JUAN CARLOS;MARQUEZ DORSCH MANUEL;PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;VALLEJO LLOPIS ANA;BURGOS LIZALDEZ MIGUEL ANGEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: MONREAL VELEZ ELIAS JOSE;MARTINEZ MOSQUERA ANTONIO MANUEL.

17/12/2010 Details of the advert (1154732)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2010) Año: 2009

25/11/2010 Details of the advert (436504) Registry data: T 15103 , F 219, S 8, H M 25881, I/A 258 (11.11.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: GIL AGUDO JUAN CARLOS.

  • Nombramientos

    Representan: CARMONA SCHMOLLING JUAN CARLOS.

18/11/2010 Details of the advert (425797) Registry data: T 15103 , F 218, S 8, H M 25881, I/A 256 ( 4.11.10).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

18/11/2010 Details of the advert (425798) Registry data: T 15103 , F 218, S 8, H M 25881, I/A 257 ( 8.11.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: MARQUEZ DORSCH MANUEL.

  • Nombramientos

    Representan: REDONDO IGLESIAS ALFREDO.

27/04/2010 Details of the advert (168524) Registry data: T 15103 , F 217, S 8, H M 25881, I/A 255 (15.04.10).

  • Revocaciones

    Apoderado: ADANERO PALOMO JOSE LUIS.

  • Nombramientos

    Apoderado: VALLEJO LLOPIS ANA.

16/12/2009 Details of the advert (1018582)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2009) Año: 2008

14/12/2009 Details of the advert (519409) Registry data: T 15103 , F 216, S 8, H M 25881, I/A 254 ( 1.12.09).

  • Revocaciones

    Apoderado: YLLERA FERNANDEZ RAFAEL;YLLERA FERNANDEZ RAFAEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: MOYA JIMENEZ ANTONIO;JAMOEL FEMKE ANNEMARIE.

Mercantile Registry documents related: 14

#CVE
Date
State
BORME-A-2011-143-28 28/07/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-72-28 13/04/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-34-28 18/02/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-240-28 17/12/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-226-28 25/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-221-28 18/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-221-28 18/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-78-28 27/04/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-239-28 16/12/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-237-28 14/12/2009 Madrid Descargar