AENA DESARROLLO INTERNACIONAL SA

Cambio de denominación social

CALLE ARTURO SORIA, 109 - 2ª PLANTA
Madrid  (28043)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 28/04/2016

MARABINI RUIZ RODRIGO

Consejero
Cese: 28/04/2016

VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 19/02/2016

GARCIA DUARTE MATILDE

Consejero
Cese: 27/08/2015

PUENTE FERRERAS BEATRIZ

Consejero
Nombramiento: 27/08/2015

LEO VIZCAINO JOSE

Consejero
Nombramiento: 29/10/2014

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 16/10/2014

MARIN SAN ANDRES FRANCISCO JAVIER

Presidente
Nombramiento: 16/10/2014

VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL

Consejero
Nombramiento: 16/10/2014

VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL

Presidente
Nombramiento: 16/10/2014

VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL

Consejero delegado solidario
Cese: 18/09/2014

FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS

Consejero
Nombramiento: 18/09/2014

SALVADORES GARCIA ALMUDENA

Consejero
Nombramiento: 16/07/2014

PUENTE FERRERAS BEATRIZ

Consejero
Nombramiento: 16/07/2014

ECHEGARAY DEL POZO FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 24/01/2014

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 14/08/2013

MARIN SAN ANDRES FRANCISCO JAVIER

Consejero delegado
Nombramiento: 14/08/2013

MARIN SAN ANDRES FRANCISCO JAVIER

Consejero
Nombramiento: 14/08/2013

MARIN SAN ANDRES FRANCISCO JAVIER

Presidente
Cese: 25/04/2013

MARABINI RUIZ RODRIGO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/04/2013

ALONSO FARTO ANA MARIA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/04/2013

GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/04/2013

ESCRIG TEIGEIRO MARIA DE LOS REYES

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 25/04/2013

OSTOS REY MARIA JESUS

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/04/2013

MARABINI RUIZ RODRIGO

Apoderado
Nombramiento: 25/04/2013

ALONSO FARTO ANA MARIA

Apoderado
Nombramiento: 25/04/2013

OSTOS REY MARIA JESUS

Apoderado
Nombramiento: 25/04/2013

ESCRIG TEIGEIRO MARIA DE LOS REYES

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by AENA DESARROLLO INTERNACIONAL SA

05/09/2017 Details of the advert (359811) Registry data: T 28206 , F 158, S 8, H M 177425, I/A 72 (28.08.17).

  • Modificaciones Estatutarias

    SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 25 Y SE REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. .

  • Cambio de denominación social

    AENA DESARROLLO INTERNACIONAL S M E SA.

28/04/2016 Details of the advert (185580) Registry data: T 28206 , F 158, S 8, H M 177425, I/A 71 (20.04.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MARABINI RUIZ RODRIGO. Cons.Del.Sol: VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL.

19/02/2016 Details of the advert (76631) Registry data: T 28206 , F 158, S 8, H M 177425, I/A 70 (12.02.16).

  • Nombramientos

    Consejero: GARCIA DUARTE MATILDE.

27/08/2015 Details of the advert (353604) Registry data: T 28206 , F 157, S 8, H M 177425, I/A 69 (20.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: PUENTE FERRERAS BEATRIZ.

  • Nombramientos

    Consejero: LEO VIZCAINO JOSE.

06/11/2014 Details of the advert (448469) Registry data: T 28206 , F 157, S 8, H M 177425, I/A 68 (29.10.14).

  • Otros Conceptos

    Se hace constar el cambio de la denominación social del socio único, siendo la actual Aena SA.

29/10/2014 Details of the advert (435584) Registry data: T 28206 , F 157, S 8, H M 177425, I/A 67 (21.10.14).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

24/10/2014 Details of the advert (427697) Registry data: T 28206 , F 156, S 8, H M 177425, I/A 66 (15.10.14).

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 77.997.780,00 Euros. Desembolsado: 77.997.780,00 Euros. Resultante Suscrito: 161.182.190,00 Euros. Resultante Desembolsado: 161.182.190,00 Euros.

16/10/2014 Details of the advert (415301) Registry data: T 28206 , F 156, S 8, H M 177425, I/A 65 ( 8.10.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: MARIN SAN ANDRES FRANCISCO JAVIER.

  • Nombramientos

    Consejero: VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL. Presidente: VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL. Cons.Del.Sol: VARGAS GOMEZ JOSE MANUEL.

18/09/2014 Details of the advert (371694) Registry data: T 28206 , F 156, S 8, H M 177425, I/A 64 (10.09.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS.

  • Nombramientos

    Consejero: SALVADORES GARCIA ALMUDENA.

16/07/2014 Details of the advert (293950) Registry data: T 28206 , F 156, S 8, H M 177425, I/A 63 ( 7.07.14).

  • Nombramientos

    Consejero: PUENTE FERRERAS BEATRIZ;ECHEGARAY DEL POZO FERNANDO.

Mercantile Registry documents related: 33

#CVE
Date
State
BORME-A-2017-169-28 05/09/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2016-81-28 28/04/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-34-28 19/02/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-163-28 27/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-213-28 06/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-207-28 29/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-204-28 24/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-198-28 16/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-178-28 18/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-133-28 16/07/2014 Madrid Descargar