ADA AYUDA DEL AUTOMOVILISTA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Extinta

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 25/07/2017

ALVAREZ CAMIÑA SERGIO

Apoderado
Nombramiento: 25/07/2017

RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA MARIA-FLAVIA

Apoderado
Nombramiento: 26/03/2015

ALVAREZ CAMIÑA SERGIO

Apoderado
Nombramiento: 26/03/2015

PASQUAU NIETO LUIS FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 26/03/2015

CABO LOPEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 06/03/2015

PEREZ DE CARCAMO MARTINEZ MARGARITA

Interventor
Nombramiento: 06/03/2015

PEREZ DE CARCAMO MARTINEZ MARGARITA

Interventor
Nombramiento: 16/02/2015

CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

Liquidador
Cese: 04/10/2013

AMIEVA ZAPICO ANGELICA

Consejero delegado
Cese: 04/10/2013

AMIEVA ZAPICO ANGELICA

Apoderado
Cese: 02/10/2012

MONTES ARGUELLES VICTOR

Presidente
Cese: 02/10/2012

MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL

Secretario
Cese: 02/10/2012

AMIEVA ZAPICO ANGELICA

Consejero delegado
Nombramiento: 02/10/2012

MONTES AMIEVA MARIA-JOSEFA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 02/10/2012

MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL

Secretario
Nombramiento: 02/10/2012

AMIEVA ZAPICO ANGELICA

Consejero delegado
Nombramiento: 02/10/2012

MONTES ARGUELLES VICTOR

Presidente
Nombramiento: 02/10/2012

MONTES ARGUELLES VICTOR

Consejero
Nombramiento: 02/10/2012

AMIEVA ZAPICO ANGELICA

Consejero
Nombramiento: 02/10/2012

NIETO ROLDAN ANGEL

Consejero
Nombramiento: 02/10/2012

MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL

Consejero
Nombramiento: 02/10/2012

AMIEVA ZAPICO ANGELICA

Vicepresidente
Nombramiento: 30/10/2009

VERA MARTIN PEÑASCO MIGUEL ANGEL

Auditor
Nombramiento: 30/10/2009

RODRIGUEZ GALAN FERNANDO

Auditor suplente
Nombramiento: 24/08/2009

MONTES AMIEVA MARIA JOSEFA

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

MARIN ARIAS BENITO ALFONSO

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2009

MARTINEZ JEREZ JUANA

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by ADA AYUDA DEL AUTOMOVILISTA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

14/04/2021 Details of the advert (169141) Registry data: T 33233 , F 156, S 8, H M 56419, I/A 39 ( 7.04.21).

  • Otros Conceptos

    EXTINCION Y CANCELACION DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS. ORDEN ETD/106/2021 DE 15 DE ENERO.

  • Extinción

25/07/2017 Details of the advert (305340) Registry data: T 33233 , F 156, S 8, H M 56419, I/A 38 (14.07.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: ALVAREZ CAMIÑA SERGIO.

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA MARIA-FLAVIA.

30/09/2015 Details of the advert (394204) Registry data: T 33233 , F 155, S 8, H M 56419, I/A 37 (22.09.15).

  • Otros Conceptos

    Ada Ayuda del Automovilista SA de Seguros y Reaseguros cede a Legalitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, las pólizas del ramo de Defensa Jurídica.

26/03/2015 Details of the advert (129097) Registry data: T 3324 , F 149, S 8, H M 56419, I/A 36 (17.03.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: ALVAREZ CAMIÑA SERGIO;PASQUAU NIETO LUIS FERNANDO;CABO LOPEZ MIGUEL ANGEL.

06/03/2015 Details of the advert (98622) Registry data: T 3324 , F 149, S 8, H M 56419, I/A 35 (25.02.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Interventor: PEREZ DE CARCAMO MARTINEZ MARGARITA.

  • Nombramientos

    Interventor: PEREZ DE CARCAMO MARTINEZ MARGARITA.

16/02/2015 Details of the advert (68344) Registry data: T 3324 , F 149, S 8, H M 56419, I/A 34 ( 9.02.15).

  • Nombramientos

    Liquidador: CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS.

  • Otros Conceptos

    Orden Ministerial de fecha 17 de diciembre de 2014, por la que el Ministerio de Economía y Competitividad acuerda la DISOLUCION ADMINISTRATIVA de la Sociedad.

  • Disolución

    Otras Causas.

04/10/2013 Details of the advert (426214) Registry data: T 3324 , F 149, S 8, H M 56419, I/A 33 (27.09.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: AMIEVA ZAPICO ANGELICA.

  • Revocaciones

    Apoderado: AMIEVA ZAPICO ANGELICA.

02/10/2012 Details of the advert (401521) Registry data: T 3324 , F 148, S 8, H M 56419, I/A 32 (20.09.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: MONTES ARGUELLES VICTOR. Secretario: MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL. Con.Delegado: AMIEVA ZAPICO ANGELICA.

  • Nombramientos

    VsecrNoConsj: MONTES AMIEVA MARIA-JOSEFA. Secretario: MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL. Con.Delegado: AMIEVA ZAPICO ANGELICA. Presidente: MONTES ARGUELLES VICTOR.

  • Reelecciones

    Consejero: MONTES ARGUELLES VICTOR;AMIEVA ZAPICO ANGELICA;NIETO ROLDAN ANGEL;MONTES AMIEVA VICTOR MANUEL. Vicepresid.: AMIEVA ZAPICO ANGELICA.

25/01/2011 Details of the advert (48001)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Enero de 2011) Año: 2009

30/10/2009 Details of the advert (455247) Registry data: T 3324 , F 148, S 8, H M 56419, I/A 31 (16.10.09).

  • Nombramientos

    Auditor: VERA MARTIN PEÑASCO MIGUEL ANGEL. Aud.Supl.: RODRIGUEZ GALAN FERNANDO.

Mercantile Registry documents related: 13

#CVE
Date
State
BORME-A-2021-69-28 14/04/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2017-140-28 25/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2015-187-28 30/09/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-58-28 26/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-45-28 06/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-31-28 16/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2013-190-28 04/10/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-190-28 02/10/2012 Madrid Descargar
BORME-B-2011-16-28 25/01/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2009-208-28 30/10/2009 Madrid Descargar